32
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 173 Wednesday, March 4, 2015 / Le mercredi 4 mars 2015 207 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. FEBRUARY 5, 2015 2015-13 Under subsection 10(1) of the Gaming Control Act and section 26 of the Interpretation Act, the Lieutenant-Governor in Coun- cil revokes Order in Council 2011-31 dated February 3, 2011. Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor ________________ Orders in Council Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordon- natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. LE 5 FÉVRIER 2015 2015-13 En vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la réglementation des jeux et de l’article 26 de la Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil révoque le décret en conseil 2011-31 pris le 3 février 2011. La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau ________________ Décrets en conseil

The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 173 Wednesday, March 4, 2015 / Le mercredi 4 mars 2015 207

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at leastseven working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

FEBRUARY 5, 20152015-13

Under subsection 10(1) of the Gaming Control Act and section26 of the Interpretation Act, the Lieutenant-Governor in Coun-cil revokes Order in Council 2011-31 dated February 3, 2011.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

Orders in Council

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordon-natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept joursouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.

LE 5 FÉVRIER 20152015-13

En vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la réglementationdes jeux et de l’article 26 de la Loi d’interprétation, lelieutenant-gouverneur en conseil révoque le décret en conseil2011-31 pris le 3 février 2011.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

Décrets en conseil

Page 2: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015

FEBRUARY 5, 20152015-15

Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints the persons listed in Appendix Aas Deputy Sheriffs, effective February 5, 2015.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

Appendix A

Bathurst Region:• Remi Godin;• René Comeau;• Santina Bosca;• Marc Roy;• Pier-Paul Landry;• Cathy St-Pierre;• Keith Basque; and• Kevin Langlais.

Campbellton Region:• Marie-Anne Mazerolle; and • Ryan Court.

Edmundston Region:• Danny Theriault;• Tomie Desjardins;• Guylaine Dorion;• Mike Martin;• Isabelle Sirois;• Andre Ouellet;• Reggie Guay;• Rodrique Michaud; and • John Pelletier.

Fredericton Region:• Bryson Jenkins;• John Latimer;• Ray Travers;• Todd Carr; and• Kyle Nash.

Miramichi Region:• Amanda Wood; and • Melanie Hachey.

Moncton Region:• Tim Geldart;• Jonathan Breau;• Brian Leger;• Justin Alderic Richard;• Claude Coulombe; and • Marcel Cormier.

LE 5 FÉVRIER 20152015-15

En vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur les shérifs, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de shérifs ad-joints les personnes dont le nom apparaît à l’annexe A, à comp-ter du 5 février 2015.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

Annexe A

Région de Bathurst• Rémi Godin• René Comeau• Santina Bosca• Marc Roy• Pier-Paul Landry• Cathy St-Pierre• Keith Basque• Kevin Langlais

Région de Campbellton• Marie-Anne Mazerolle• Ryan Court

Région d’Edmundston• Danny Thériault• Tomie Desjardins• Guylaine Dorion• Mike Martin• Isabelle Sirois• André Ouellet• Reggie Guay• Rodrique Michaud• John Pelletier

Région de Fredericton• Bryson Jenkins• John Latimer• Ray Travers• Todd Carr• Kyle Nash

Région de Miramichi• Amanda Wood• Mélanie Hachey

Région de Moncton• Tim Geldart• Jonathan Breau• Brian Leger• Justin Aldéric Richard• Claude Coulombe• Marcel Cormier

Page 3: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 209 Gazette royale — 4 mars 2015

Saint John Region:• Adam Bertolini;• Andrew Lajoie;• Timothy Rooney;• Malakyi Goldsworthy;• William Mattsson;• Brian Parker;• Joseph Savoie;• Nathan Bell;• Paulina Bolduc;• Phillip Greer;• Ryan Martin;• Heather Ashley Atherton;• Tori White; and• Megan Williams.

St. Stephen Region• Andrew Reid.

Woodstock Region:• Ricky Ketch;• Scott Hamilton;• Emily Martin;• Eric McElroy; and• Ronald Crawford.

________________

FEBRUARY 5, 20152015-17

Under paragraph 8(1)(c) of An Act Respecting the NewBrunswick Medical Society and the College of Physicians andSurgeons of New Brunswick, Chapter 87 of the Acts of NewBrunswick, 1981, the Lieutenant-Governor in Council appointsRuth Lyons, Tide Head, New Brunswick, as a public member ofthe Council of the College of Physicians and Surgeons of NewBrunswick, for a term of three years, effective February 5, 2015.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

FEBRUARY 5, 20152015-23

Under subsections 8(1) and 9(1) of the Combat Sport Act, theLieutenant-Governor in Council appoints Tina Thibodeau,Riverview, New Brunswick, as a member of the NewBrunswick Combat Sport Commission, for a term of threeyears, effective February 5, 2015.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

Région de Saint John• Adam Bertolini• Andrew Lajoie• Timothy Rooney• Malakyi Goldsworthy• William Mattsson• Brian Parker• Joseph Savoie• Nathan Bell• Paulina Bolduc• Phillip Greer• Ryan Martin• Heather Ashley Atherton• Tori White• Megan Williams

Région de St. Stephen• Andrew Reid

Région de Woodstock• Ricky Ketch• Scott Hamilton• Emily Martin• Eric McElroy• Ronald Crawford

________________

LE 5 FÉVRIER 20152015-17

En vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi relative à la Société médi-cale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins etchirurgiens du Nouveau-Brunswick, chapitre 87 des Lois duNouveau-Brunswick de 1981, le lieutenant-gouverneur enconseil nomme Ruth Lyons, de Tide Head (Nouveau-Brunswick), membre du conseil du Collège des médecins etchirurgiens du Nouveau Brunswick à titre de représentante dupublic, pour un mandat de trois ans, à compter du 5 février2015.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

LE 5 FÉVRIER 20152015-23

En vertu des paragraphes 8(1) et 9(1) de la Loi sur les sports decombat, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme TinaThibodeau, de Riverview (Nouveau-Brunswick), membre de laCommission des sports de combat du Nouveau-Brunswick,pour un mandat de trois ans, à compter du 5 février 2015.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

Page 4: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 210 Gazette royale — 4 mars 2015

051946 051946 N.B. INC.514590 514590 N.B. Ltd.600875 600875 N.B. LTD.601345 601345 N.B. LTD.619290 619290 N.B. INC.625295 625295 N.B. Inc.625676 625676 NB INC.632164 632164 NB Inc.632167 632167 N.B. LTD.638101 638101 N.B. Inc.650894 650894 NB Inc.651238 651238 N.B. LTD.657534 657534 NB Inc.663731 663731 N.B. INC./ 663731 NB INC.663787 663787 N.B. INC.663871 663871 NB Inc.663947 663947 NB INC.664024 664024 NB INC.664045 664045 N.B. Ltd.664066 664066 N.B. Ltd.664092 664092 NEW BRUNSWICK INC.664129 664129 NB Corp.- 664129 N.B. Corp.664232 664232 New Brunswick Incorporated663656 A Plus Drywall Ltd.664186 ABI Apprentissage, buts & interventions

ltée657502 AC Boyd Enterprises Inc.664047 ALTERNATE INCOME

DEVELOPMENT CORP.663848 AMERICAN CANADIAN NATIVE

SEAFOOD CORP.663780 Arnprior Solar Inc.644669 ASSURANCES SYLVIE ROY INC.651146 Atlantic Drywall Interiors Ltd.601014 BACKUP INTERNATIONAL INC.625496 Berlin Investments Inc.625809 Better Heat Pump Solutions Inc.664121 Bruised Media Group Inc.631649 Buba Canada Adventures Ltd.638196 BULGOGI LTD.057176 C. HALL HEAVY EQUIPMENT

REPAIR LTD.039429 C.J.N.H. ENTERPRISES INC.644714 C.M.G.J. TRUCKING INC.664157 C4 Construction Inc.032097 CAPITAL PLASTERING &

CONCRETE FLOORS LTD.606887 CINÉ-PARC VÉNUS (2003) LTÉE644603 CLASSIC FAMILY FURNISHINGS

LTD.644856 Club Marz Inc.511884 Crawford Ironworks Inc.

049801 CREATIVE IDEAS INTERNATIONAL INC.

601063 Crestline Electric Ltd.612713 D & T Forestry Ltd.511875 DCB Welding & Fabrication Inc.514502 Design Workshop Ltd. - Atelier de design

Ltée663951 Doug Geldart Trucking LTD.663628 Eco Fab Mama Ltd.506954 English Homes & Renovations Ltd.638518 Excavation des 3 lacs Inc.632035 FH - Future Homes & Renovations Inc.619222 Field Services Canada Inc.631752 Five Elements Ltd.651029 Five Senses Gourmet Inc.657311 GENR Global Earth Natural Resources

Inc.054215 GOOD VALUE STORES LTD.511950 hawkins.nb.ca Real Estate Ltd.631704 IMPERFECTIONS INC.663959 ISDN Services Inc.638080 J&T Gillin Holdings Inc.008683 J’S WELDING & SERVICE LTD.663705 J. WARD CONSULTING INC.664199 J.A.R. House Moving Inc.650835 JACQUET RIVER FLOWER &

NURSERY LTD.631851 JGR Renovations Inc.601280 JOHN’S R V REPAIRS LTD.033768 K. J. C. HOLDINGS LIMITED664228 Kan-Den International Import & Export

Co. Ltd.638222 Karpo Ventures Inc.601350 L. D. TOP ROOFING LTEE644638 LANCASTER FINANCIAL SERVICES

INC.664184 Landfusion Construction &

Developments Inc.044851 LEBANESE PLUS INC.664088 Les produits Pilou Inc./Pilou Products Inc.625835 LIKEN TRADE LTD663827 LOST VALLEY BREWING LTD.663732 M and K Trucking Incorporated650966 Mark Johnson Forestry Inc.509358 MC2 EDUCATION CONSULTANTS

INC.619103 Mercer Ventures Limited601357 Mountain Food Inc.664134 NATRIC Enterprises Inc.631590 NewWest Capital Management Canada

Inc.632119 NIFCO LTD.612591 Norton International Pharmaceutical Inc.

663976 Office Lounge 51 (2012) Inc.638225 ONE STOP RECYCLERS INC.511960 Overboard Diving Ltd.618835 PARTITO SALES LTD631826 PCI Blacktop Inc.644948 PELICAN COVE CONSULTING LTD.612429 POISSONNERIE OUELLETTE FISH

MARKET INC.044798 PRESTIGE CONCRETE LTD.511908 PROFILES ATLANTIC INC.631682 QUILLES G. PLUS INC.504872 R. GIRARD & SONS LUMBER LTD.044970 R.D.N.S. Investments Inc.606567 Raven’s Sun Management Inc.511941 REFLECTIONS PHOTOGRAPHY INC.663720 Reliable Insight Corp.039094 RIVER VALLEY FISH CO. LTD.057166 ROCAR DEVELOPMENTS LTD.638591 ROTHESAY WOODWORKING LTD.612478 S & S Mini and Modular Home Moving

Inc.511973 Saulnier Paint & Supplies Inc.664070 SCOTT GARNETT TRUCKING INC.042117 SEAWOOD ESTATES DEVELOPERS

LTD.663774 Shaw Online Ventures Ltd.035550 SISCOR CORPORATION657348 SMDIGroup, Inc.619223 Stone & Webster Canada Holding Two,

Inc.015721 SULLIVAN’S TRUCKING LTD618684 Super Wheels (2005) Ltd.601273 Sweet Eastern Mussel Farms Inc.606673 SYNERGY MATERIAL &

PROCUREMENT INC.644639 Taylor’s Special Care Home Inc.663960 THE BREAKWATER BAR LTD.606563 TJC HOLDINGS LTD.651213 TMTF Agricultural Services Ltd.016243 TONER BROS. LTD.663704 TONY’S YUMMY RESTAURANT

LIMITED631809 Tri-City Towing Inc.651245 TRI-VOLT ELECTRIC LTD.663680 TSI TRANSPORT SYSTEMS

IMPLEMENTATION LTD.657861 TTCK Professional Services Corp.625834 VALET DEVELOPMENT LTD606892 VALLEY SOFTWARE LTD.601428 VIRTUAL PLANNING INC./

PLANIFICATION VIRTUELLE INC.663971 Wallace Transport Inc.

Avis de dissolution de corporations provinciales et d’annulationde l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Avis de dissolution de corporations provincialesSachez que les corporations provinciales suivantes ont été dissoutes endate du 13 février 2015 en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi sur lescorporations commerciales, puisque lesdites corporations ont fait dé-faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re-quis par la Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du13 février 2015.

Loi sur les corporationscommerciales

Notice of dissolution of provincial corporations and cancella-tion of the registration of extra-provincial corporations

Notice of dissolution of provincial corporationsTake notice that the following provincial corporations have been dis-solved as of February 13, 2015, pursuant to paragraph 139(1)(c) of theBusiness Corporations Act, as the said corporations have been indefault in sending to the Director fees, notices and/or documents re-quired by the Act. Certificates of Dissolution have been issued datedFebruary 13, 2015.

Business Corporations Act

____________________________________________________

Page 5: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 211 Gazette royale — 4 mars 2015

657432 1214851 Alberta ULC651031 1561823 ONTARIO LIMITED644866 2021154 ONTARIO INC.663667 2313329 ONTARIO INC.663783 3611507 Canada Inc.657555 A-MAZVISION INC.663577 Aucoin Aucarré INC.

638366 BLACK’S PHOTO CORPORATION/CORPORATION BLACK PHOTO

663986 CONSTRUCTION A.G.S. INC.657611 D.P. MURPHY INC.638438 SIMARD-BEAUDRY

CONSTRUCTION INC.

651013 TRANSGLOBE GENERAL PARTNER INC.

651014 TRANSGLOBE REIT GENERAL PARTNER LIMITED

644492 Yellow Rose Enterprises Ltd.

023768 CLUB DE MOTONEIGE LA GRANDE RIVIERE INC.

664182 East Coast Comic Expo Inc.618853 EQUIPE ACADIE LTÉE644874 Flowers Cove Aquaculture Inc.

657363 Fondation Restigouche Arts & Culture Foundation Inc.

664141 HEADR for Haiti Ltd.022159 New Journey Ministries Inc.632018 Richmond Corner Preschool Inc.

663992 S.N.A.P. ATLANTIC GROUP INC.023173 THE SHOGOMOC HISTORICAL AND

MODEL RAILROAD CLUB INC.

643868 BAY ELECTRIC643442 Cambridge Cove Adventures643723 EASY BUYS643693 LEBOUTHILLIER LEBOUTHILLIER

ENTREPRISE

643201 LR Training/Formation643742 NATURE’S BOUNTY GIFTS643411 Onsite PC Tutor643091 SMALLWOOD’S FAMILY

RESTAURANT

643762 The Supreme Matrix610809 TIDEWATER INN643380 Ultimate Hockey

Notice of cancellationof registration of extra-provincial corporations

Take notice that the registrations of the following extra-provincial cor-porations have been cancelled as of February 13, 2015, pursuant toparagraph 201(1)(a) of the Business Corporations Act as the said cor-porations have been in default in sending to the Director fees, noticesand/or documents required by the Act:

Avis d’annulation del’enregistrement des corporations extraprovinciales

Sachez que l’enregistrement des corporations extraprovinciales sui-vantes a été annulé en date du 13 février 2015 en vertu de l’alinéa201(1)a) de la Loi sur les corporations commerciales, puisque lesditescorporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits,avis et/ou documents requis par la Loi :

Avis de dissolution de compagnies provincialesSoyez avisé que les compagnies provinciales suivantes ont été dis-soutes en date du 13 février 2015 en vertu de l’alinéa 35(1)c) de la Loisur les compagnies, puisque lesdites compagnies ont fait défaut defaire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis parla Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du 13 février2015.

Loi sur les compagnies

Notice of dissolution of provincial companiesTake notice that the following provincial companies have been dis-solved as of February 13, 2015, pursuant to paragraph 35(1)(c) of theCompanies Act, as the said companies have been in default in sendingto the Director fees, notices and/or documents required by the Act. Cer-tificates of Dissolution have been issued dated February 13, 2015.

Companies Act

SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi surl’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellationscommerciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a annulé, le13 février 2015, en vertu de ladite loi, l’enregistrement des certificatsde sociétés en nom collectif indiqués à l’Annexe « A » ci-jointe et descertificats d’appellations commerciales des commerces indiqués àl’annexe « B » ci-jointe en raison du fait que ces firmes ou commercesont négligé de faire enregistrer des certificats de renouvellementconformément à l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7)de ladite loi, selon le cas.

Loi sur l’enregistrement dessociétés en nom collectif et

des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part-nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,the Registrar under the said Act has cancelled, effective February 13,2015, the registration of the certificates of partnership of the firms setforth in Schedule “A” annexed hereto and the certificates of businessnames of the businesses set forth in Schedule “B” annexed hereto byreason of the fact the said firms and businesses have failed to registercertificates of renewal in accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) orsubsection 3.1(2) or 9(7), as the case may be applicable, of the said Act.

Partnerships and BusinessNames Registration Act

Schedule “A” / Annexe « A »Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

____________________________________________________

Page 6: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 212 Gazette royale — 4 mars 2015

611064 Advanced Permanent Make-up Artist Artiste en maquillage permanent avancée

643674 All Stone Landscape & Masonry Products643768 Animalerie Safari +643722 ARISTA FARM611193 ARTFUL ACRE643381 Audio & Street Performance (ASP)643495 Automatic Air Atlantic643379 Avide Design Build643721 AZTEC AUTO & TRUCK SALES &

SERVICE643537 BASIN BLACK BEAR OUTFITTING &

CAMPING643560 Belmont Flats643365 BOUTIQUE CHEZ MICHELLE643564 Brucker Enterprises643020 CAN AM ESCORTS341090 CANINE CREATIONS611020 Coastal Breeze Gifts643378 CONCEPTION-CONSTRUCTION

AVIDE643590 CONNOLLY CONSTRUCTION AND

RENOVATIONS643577 CONWAY GREETINGS643097 Craft and Grow643861 CUSTOM AUTO GLASS AND TRIM643681 Denim Experience643420 DES CONTRACTING643541 Diamond Demolition643559 Domaine Nature Estates643545 DownEast Discount Auto643369 Dreams in Seams643690 ELEMENTAL Health & Fitness

Consulting643731 ELITE VIRTUAL ADMINISTRATION643728 EMILE’S ROOFING643399 End Of Abstract643874 Engaging Entertainment643372 FABULOUS FINGERTIPS643740 FM AUTO643604 G & G Renovations643676 G-Marketing643847 G. ELK Property Management643534 G.B. Ross Consulting643439 GARAGE FERNAND FRASER643732 GARLAND STUDIOS643387 Georges Leger Building Maintenance &

Repair

643382 Gray’s Fluid Power643867 Green Acres Property Services643661 Guitard Auto Sales643549 Hands On Learning Centre643472 Harry’s Custom Cabinets642622 Heavenly Mobile Aesthetics643509 Heritage Soapworks643765 HK Technology Consultants643270 HOLLANCO INTERNATIONAL643652 Homestead Heat Pumps610840 House of Windows + Doors643613 Illusions Better643608 Imagine Floor Covering643607 Impact Promo643612 Inspirations Best643614 Irresistible Good643539 ITL Innovative Technologies Live643704 Jean’s Quality Roof643842 JFC TRUCKING642498 Joe Computer Repairs611457 L H S SALES643332 Law Office of Andrew Harrison643816 Le Decker Diner332671 LEWCO643461 Linda’s Flower Designs643448 Lisa’s Home Cooking643425 Little Party Animals643779 Lucky Bamboo Restaurant643494 Ma griffe d’Art643523 Maple Leaf Inspections643720 Maritime Safety Educators643630 MARTINIS PUB AND GRILL643453 Matt Bertin Painting643820 MCDERMOTT’S PUB AND INN611028 McShane’s Transmission643446 Memorial Candle Tributes643679 MRAAS GLOBAL643787 NAGS HEAD PUB & PIZZA643341 NATURAL DESIGNS

CONSTRUCTION643600 NETTIE HOGG REAL ESTATE643617 NORTHERN CHINESE KITCHEN,

ST. JOHN643708 Nu Organic Burial643609 Omni Floorcoverings643610 Omniflor643838 POLLOCK’S SILVICULTURE643729 POOTECH SERVICES611726 Premier Salons

643345 Presley’s Lounge643342 Prestige Moving & Storage643451 Pro-Shade Window Film643348 PROFIX MAINTENANCE & REPAIR643392 Pure Green Lawn Care & Property

Maintenance643416 Ready Chef Enr.643654 ROCKIN’ N RACIN’ COLLECTIBLES643364 ROGER YOUNG’S BRAKE AND

MUFFLER SHOP643606 Ross Inman Electrical611103 Rusty’s Lunch & Grill643683 S.C. Clinique Masso Essentiel642294 Salon de Coiffure Moderne Chez Céline611240 SCOTT’S EXCAVATING643398 Sensible Home Staging & Redesign643410 SIEMENS HEALTHCARE

DIAGNOSTICS643767 Sour Grape611005 STANLEY CORNER CONVENIENCE643611 Stevens-Dufour643307 SYNERGY AUTO SOURCE AND

SALES643535 T.M. Certified Emergency Response

Training643177 Taylor Made Taxidermy643393 TFM Auto Repair610845 THE DOWN EAST BREW STORE346400 THE ENCON GROUP/LE GROUPE

ENCON611725 The Hair Salon at Sears611678 THE MORTGAGE CENTRE643658 The Party Zone Plus643621 The Rough at Fox Creek Condominium643718 The Vintage Lunch Box610992 TheHRdept.ca643565 THERESA’s PLACE643688 TopQual Atlantic Canada643450 Totally Organized With Penney643492 Tradewinds ecoenergy Solutions

éconergétiques643777 Under Your Feet Installation643686 Vie Lounge and Tapas Bar643666 Westphalia Adventures643687 Wind Turbine Systems Atlantic Canada610988 YVETTE MAZEROLLE FOOT CARE

Schedule “B” / Annexe « B »Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales

Page 7: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 213 Gazette royale — 4 mars 2015

Ferme Alva Farm Inc. Saint-Maurice 680729 2015 01 28

680820 NB Ltd. Moncton 680820 2015 02 03

Kojiabe Image Design Studio Inc. Saint John 680839 2015 02 04

Kingdon Property Management Ltd. Fredericton 680854 2015 02 05

SOS TACTICAL INC. Dieppe 680855 2015 02 05

Dr. Michael Armitage Professional Corporation New Maryland 680856 2015 02 05

680869 NB Ltd. Moncton 680869 2015 02 05

Vautour Distribution Inc. Moncton 680870 2015 02 05

Dr. Janet McGinnis Professional Corporation Saint John 680872 2015 02 05

JY STC Entertainment Inc. Fredericton 680876 2015 02 05

680877 (N.B.) INC. Moncton 680877 2015 02 05

WAQ PRODUCTION LTD. Saint John 680878 2015 02 05

GY Industries Inc. Fredericton 680886 2015 02 06

680887 NB Inc. Caraquet 680887 2015 02 06

The McAdam Group Inc. Seeleys Cove 680893 2015 02 06

Bell Crop Services Inc. Harvey 680899 2015 02 06

ISA TRADING LTD. Riverview 680902 2015 02 06

EQNet Communications Inc. Fredericton 680903 2015 02 08

MS TTS Global Distribution Inc. Fredericton 680904 2015 02 09

Dr. Robert Pomerleau Professional Corporation Rothesay 680907 2015 02 09

680909 NB Inc. Rothesay 680909 2015 02 09

ELITE GLASS INCORPORATED Saint John 680912 2015 02 09

LK ELECTRONICS DESIGN INC. Fredericton 680914 2015 02 09

Siteimprove Inc. Simonds 680934 2015 02 09

680935 NB Corp. Petit-Rocher 680935 2015 02 09

Eagle Atlantic Commercial Flooring Ltd. Moncton 680938 2015 02 10

680940 NB Ltée Lamèque 680940 2015 02 10

Lat Vi Tailors Inc. Saint John 680943 2015 02 10

WebAMG Canada Inc. Saint John 680947 2015 02 10

680956 N.B. INC. Charlo 680956 2015 02 11

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 8: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 214 Gazette royale — 4 mars 2015

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on February 10, 2015 under the name of “680940 NB Ltée”, being corporation #680940, notice isgiven that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the “Schedule – Share Structure /Annexe – Organisation du capital social” to the attached articles.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 10 février 2015 à « 680940 NB Ltée », dont le numéro de corporationest 680940, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé corrigeant le « Schedule – ShareStructure / Annexe – Organisation du capital social » dans les articles ci-joints.

_____________________________________________________

IORDAN GRAPHIC CONSTRUCTION INC. Moncton 680957 2015 02 11

Norquay Holdings Ltd. Lower Queensbury 680962 2015 02 11

Flow Healthcare Inc. Saint John 680964 2015 02 11

680966 NB Corp. Belledune 680966 2015 02 11

Blue Fox Strategies Inc. Quispamsis 680968 2015 02 11

HUB CITY GROCER INC. Moncton 680969 2015 02 11

680970 NB Corp. Saint John 680970 2015 02 11

KLC Miramichi Holdings Inc. Bathurst 680971 2015 02 11

M. Hussey Consulting Inc. Saint John 680974 2015 02 11

P. Calvert Construction Inc. Dalhousie 680980 2015 02 12

C&E Crestfield Holdings Ltd. Moncton 680982 2015 02 12

LEAF ENGINEERING CORPORATION Quispamsis 680986 2015 02 12

680987 NB Inc. Woodstock 680987 2015 02 12

CODIAC ORGANICS LTD. Moncton 680988 2015 02 12

V-Red Prospects Inc. Fredericton 680993 2015 02 12

Knott Holdings Inc. Dieppe 681002 2015 02 12

DYKER ENTERPRISES LTD. 040012 2015 02 10

500017 N.B. INC. 500017 2015 02 06

648030 N.B. Ltd. 648030 2015 02 10

A & S Electric Ltd. 654219 2015 02 11

671363 N.B. INC. 671363 2015 02 09

Outside the Box Accounting Inc. 679668 2015 02 06

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 9: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 215 Gazette royale — 4 mars 2015

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of amendment issued on February 10, 2015 under the name of “648030 N.B. Ltd.”, being corporation #648030, notice isgiven that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of amendment correcting the “Schedule – Share Structure /Annexe – Organisation du capital social” to the attached articles.

Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 10 février 2015 à « 648030 N.B. Ltd. », dont le numéro de corporation est 648030,le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de modification corrigeant le « Schedule – Share Structure /Annexe – Organisation du capital social » dans les articles ci-joints.

_____________________________________________________

000491 NB Ltd. Rolly’s Wholesale Ltd. 000491 2015 02 12

Rolly’s Holdings Ltd. ROLLY’S DISCOUNT WHOLESALE LTD. 035318 2015 02 12

WOODS TIMBER INC. 507024 NB Ltd. 507024 2015 02 11

CEAFOOD MARKETELLA INC. LU Market Consulting Inc. 635095 2015 02 12

LUCISA HOLDINGS INC. 635429 NB Inc. 635429 2015 02 05

656123 N.B. Ltd. Accreon Investments Inc. 656123 2015 02 05

656347 N.B. Inc. Eagle Flooring Commercial Ltd 656347 2015 02 09

6th Man Inc. 678315 N.B. Inc. 678315 2015 02 05

ATLANTICAN FISHERIES INC 679496 N.B. Inc. 679496 2015 02 09

_____________________________________________________

VOLUSIA ENTERPRISES INC. VOLUSIA ENTERPRISES INC.600990 NB INC.

Miramichi 680209 2015 01 01

AAA Real Estate Corp. AAA Real Estate Corp.665222 NB Inc.679521 NB Inc.679522 NB Inc.

Fredericton 680911 2015 02 07

ATLANTIC OLIVER RETREAD LTD. ATLANTIC OLIVER RETREAD LTD.679878 N.B. Inc.

Dieppe 680978 2015 02 12

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

Page 10: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 216 Gazette royale — 4 mars 2015

CLIFF JONES ELECTRICAL SPECIALTY SERVICE LTD. Moncton 033177 2015 02 05

NEPTUNE PUBLISHING COMPANY LTD. Rothesay 034872 2015 02 02

PROCRAFT INDUSTRIAL LTD. Moncton 051956 2015 02 11

501501 NB LTD. Sussex Corner 501501 2015 02 04

511904 N.B. LTD. Saint John 511904 2015 02 02

PROCHEM ATLANTIC INC. Moncton 626807 2015 02 11

SDMS SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Saint John 636915 2015 02 10

Springgreen Ventures Limited Saint John 637490 2015 02 10

Cool Grey International Limited Saint John 638370 2015 02 10

641916 N.B. Inc. 641916 N.-B. Inc. Dieppe 641916 2015 02 02

Calluna International Limited Saint John 658847 2015 02 10

Island Propellers & Welding Ltd. Grand Manan 661440 2015 02 05

Winston Ventures Limited Saint John 667111 2015 02 10

AES Contracting Ltd. Fredericton 680437 2015 02 02

_____________________________________________________

JOEY’S PUB & EATERY INC. 645519 2015 02 09

_____________________________________________________

REEN’S FASHIONS LTD. 013783 2015 02 09

602520 N.B. LTD. 602520 2015 02 09

The Gaudes Group Inc. 648991 2015 01 11

U C Under Construction Ltd. 657199 2015 02 02

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a restated certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de constitution mise à jour a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 11: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 217 Gazette royale — 4 mars 2015

Brookfield Real Property Solutions Inc. Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

680713 2015 01 28

WealthSimple Financial Inc. Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

680740 2015 01 29

The HC Canada Operating Company, Ltd. Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

680741 2015 01 29

Mialisia Canada Inc. Québec / Quebec Kelsey D. BinghamMoncton

680753 2015 01 29

Smartarget Mobile Ads Inc. Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

680767 2015 01 30

Planète Poutine et cie Maître Québec / Quebec Adel GöncziMoncton

680775 2015 01 30Franchiseur Inc.

Allen Wong & Associates Insurance Agency Limited

Ontario Gerald M. LawsonSaint John

680776 2015 01 30

Water’s Edge Publishing Inc. Canada Valérie FoucherMoncton

680789 2015 01 30

NMB East (GP) Ltd. Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

680799 2015 02 02

SERVICES FINANCIERS OPS INC. OPS FINANCIAL SERVICES INC.

Québec / Quebec Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

680832 2015 02 04

TRI-UNION FROZEN PRODUCTS CANADA, ULC

Colombie-Britannique /British Columbia

Arthur T. DoyleSaint John

680858 2015 02 05

DISTRIBUTION 83 INC. Canada Serge PronovostVillage Blanchard

680859 2015 02 05

EAU DE SOURCE NATURELLE 83 PPM INC. 83 PPM NATURAL SPRING WATER INC.

Canada Serge PronovostVillage Blanchard

680860 2015 02 05

Universal Rail Contractors Ltd. Manitoba Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

680880 2015 02 06

AON SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT INC.

Canada Deborah M. PowerFredericton

680897 2015 02 06

BIG LOBSTER SEAFOOD INCORPORATED

Ontario Thomas J. ThompsonDieppe

680945 2015 02 10

ECONO-MALLS HOLDINGS #19 INC.GESTION ECONO-MALLS #19 INC.

Canada McInnes Cooper CSDServices Inc.Fredericton

680954 2015 02 11

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 12: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 218 Gazette royale — 4 mars 2015

FORGE FIRST ASSET MANAGEMENT INC.

Ontario Deborah M. PowerFredericton

680955 2015 02 11

_____________________________________________________

VANTAGE FRANCHISING (CANADA) INC. Canadas BV Inn Inc. 664151 2015 02 03

Hexion Canada Inc. Momentive Specialty Chemicals Canada Inc.Produits Chimiques Spécialisés Momentive Canada Inc.

679826 2015 01 29

_____________________________________________________

Arthur J. Gallagher Canada Limited

Arthur J. Gallagher Canada Limited Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680643 2015 01 23

LEWER CANADA LTD. LEWER CANADA LTD. Willard M. JenkinsSaint John

680787 2015 01 30

HALLIBURTON CANADA ULC HALLIBURTON CANADA ULC Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680795 2015 02 02

RHI CANADA INC. RHI Canada Inc. Arthur T. DoyleSaint John

680801 2015 02 02

Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée

YELLOW PAGES GROUP CORP.-GROUPE PAGES JAUNES CORP.YPG Financing Inc. –Financement YPG Inc.

Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680862 2015 02 05

Yellow Pages Limited Pages Jaunes Limitée

Yellow Media LimitedYellow Média Limitée

Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680863 2015 02 05

FUGRO CANADA CORP. Fugro Canada Corp. Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680864 2015 02 05

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Page 13: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 219 Gazette royale — 4 mars 2015

Saint-Éloi Chapel Foundation, Inc. / Fondation Chapelle Saint-Éloi, Inc. Saint-André 680874 2015 02 05

360 Stand Inc. Saint John 680890 2015 02 05

Fredericton Marathon Inc. Fredericton 680894 2015 02 06

Rockland Mudrunners ATV Club Inc. McAdam 680919 2015 02 09

Hartland Community Garden Inc. Hartland 680951 2015 02 10

Cooke Foundation Inc. Saint John 680959 2015 02 11

_____________________________________________________

MONCTON GOLF & COUNTRY CLUB LIMITED 011255 2015 01 29

ST. MARTIN’S-IN-THE-WOOD, ANGLICAN CHURCH HOME INC. 022734 2015 02 05

The New Brunswick Registered Music Teachers’ Association 674875 2015 02 09

_____________________________________________________

BATHURST KNIGHTS OF COLUMBUS, LIMITED

BATHURST COUNCIL 1935, LIMITED 090689 2015 02 04

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires ont été émises à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent, which include a change in name,have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale,ont été émises à :

DateNew Name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 14: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 220 Gazette royale — 4 mars 2015

Domaine Dover Estates NORON INC. Scoudouc 680073 2014 12 30

Nashwaak Riverbank Restoration Association

James MacFarlaneBrent SansomBernice MacFarlane

Nashwaak Bridge 680608 2015 01 22

Ray’s Mulching Raymond Mazerolle Saint-Louis-de-Kent 680621 2015 02 05

Sammy Mallet Renovation & Construction

Sammy Mallet Cap-Pelé 680627 2015 01 22

MAC’s Fish & Chips Michelle Hanrahan Oromocto 680668 2015 01 23

EASY STREET COMMUNICATIONS

Tracy Bell Dieppe 680703 2015 01 27

Keifer Bell Painting Keifer Bell Moncton 680704 2015 02 11

Atlantic Cash & Pawn DEAD END AUTO PARTS &RECYCLING LTD.

Fredericton 680705 2015 01 28

Brookfield RPS Brookfield Real PropertySolutions Inc.

Saint John 680714 2015 01 28

Hannah Gifts & Decor Southern Summer Inc. Moncton 680755 2015 01 29

FIVE FATHOMS BRAND SHEDIAC LOBSTER SHOP LTD. Shediac 680756 2015 01 29

SHEDIAC BAY BRAND SHEDIAC LOBSTER SHOP LTD. Shediac 680757 2015 01 29

David C.A. Williams Renovations

David Williams Harvey 680760 2015 01 29

PAVAGE L.C.L. PAVING L.C.L. EXCAVATION (2006)INC.

Charlo 680786 2015 01 30

Lyons Den Fitness Melanie Lyons Keswick Ridge 680790 2015 01 30

Nose To Toes Petcare by Deb Debra Jean Kierstead Fredericton 680793 2015 01 30

F. Wallace Clancy & Son Insurance

Arthur J. Gallagher Canada Limited

Saint John 680797 2015 02 02

CARAQUET LAVE-AUTO ENR. 606299 N.B. LTÉE Caraquet 680803 2015 02 02

A.W.O.L. Brewery A.W.O.L. BREWERY CORP. Riverview 680811 2015 02 02

Terrapure Environmental Revolution EnvironmentalSolutions LP

Saint John 680834 2015 02 04

Terrapure Environmental Revolution Landfill LP Saint John 680835 2015 02 04

Terrapure Environmental Revolution ORS LP Saint John 680836 2015 02 04

Terrapure Environmental Revolution VSC LP Saint John 680837 2015 02 04

Repairs Plus Property Services

Peter Lorne Wilson Moncton 680845 2015 02 04

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 15: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 221 Gazette royale — 4 mars 2015

Brookside Wellness Centre Shiona McIntosh Fredericton 680846 2015 02 04

J.E.M. Counselling Service Jeanette Merriam Mactaquac 680848 2015 02 04

Open Your Art Angela Black McLeod Hill 680849 2015 02 04

Hi Gorgeous Beauty Training Julie Boudreau Dieppe 680853 2015 02 04

STUDIO 678 Linda Lou Rose Woodstock 680857 2015 02 05

Encadanse École de danse 680006 N.-B. Ltée Rivière-à-la-Truite 680861 2015 02 05

itravel2000.com 8635919 CANADA INC. Saint John 680865 2015 02 05

itravel2000 8635919 CANADA INC. Saint John 680866 2015 02 05

ASSUREX HEALTH ASSURERX CANADA, LTD. Saint John 680867 2015 02 05

Cara’s Beauty Magic Cara Chase Fredericton 680868 2015 02 05

Edgewood Communications Claire MacIntyre New Maryland 680871 2015 02 05

ENGEL(S)MOODS Blyala Angele Moncton 680873 2015 02 05

Wills for the Unwilling Jodi Lee-White Fredericton 680875 2015 02 05

Intervera Halliburton Partners CanadaULC

Saint John 680881 2015 02 06

Intervera Data Solutions Halliburton Partners CanadaULC

Saint John 680882 2015 02 06

Petris Technology Halliburton Partners CanadaULC

Saint John 680883 2015 02 06

EuroPump Halliburton Partners CanadaULC

Saint John 680884 2015 02 06

EuroPump Systems Halliburton Partners CanadaULC

Saint John 680885 2015 02 06

JACOS PIZZA & DONAIR Jack Khoury Saint John 680892 2015 02 06

Denis Babineau Renovations Denis Babineau Grand-Barachois 680895 2015 02 06

Comptabilité Outside the Box Accounting

Outside the Box AccountingInc.

Moncton 680896 2015 02 05

Guru Nutrition Express Danny Bevans Dieppe 680898 2015 02 06

B E C Construction David LeBlanc Killams Mills 680900 2015 02 06

All Kind Moving Christopher Fazio Fredericton 680901 2015 02 06

Victoria Coy Photography Victoria Coy Miramichi 680906 2015 02 09

R.A. Studios Ian Noble Fredericton 680908 2015 02 09

Sky High Catering Hannah Dupuis Saint John 680910 2015 02 09

Darkside Athletics Jeremie Page Riverview 680913 2015 02 09

Fundy Geoscience Denis Fitzpatrick Notre-Dame 680915 2015 02 09

I Live with Art Tandi Hooper-Clark Rothesay 680916 2015 02 09

The Taylor MacDougall Training Group

Taylor MacDougall New Maryland 680917 2015 02 09

AUBAINERIE CHEZ FLO GESTION FLORENCE INC. Lamèque 680918 2015 02 09

EAST COAST TALENT ACQUISITION

ATM Consulting Ltd. Maces Bay 680922 2015 02 09

Page 16: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 222 Gazette royale — 4 mars 2015

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMPartnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

In relation to the certificate of business name registered on February 5, 2015 under the Act, under the name of “Edgewood Communications”, beingfile #680871, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the name of the person registering the name be correctedto read “Clare MacIntyre” and that the address at section 6 be corrected to read as follows: “97 Cortland Avenue, New Maryland NB”.

Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 5 février 2015 en vertu de la Loi sous le nom de « EdgewoodCommunications », dont le numéro d’appellation commerciale est 680871, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que lenom de la personne enregistrant l’appellation commerciale soit corrigé pour qu’il se lise comme suit : « Clare MacIntyre » et que l’adresse à lasection 6 soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « 97 Cortland Avenue, New Maryland NB ».

_____________________________________________________

Roof Tiling N.B. Justin Dumont Indian Mountain 680926 2015 02 09

THEDA ENTERPRISES David Green Stanley 680932 2015 02 09

ATCHISON CONSULTING GROUP Connor Atchison Upper Gagetown 680933 2015 02 09

Fredericton English Training Derek Bradford Fredericton 680937 2015 02 09

Gateway Loans Marc Comeau Moncton 680939 2015 02 10

Votchë, services musicaux, musical services

Rose Marie Bernaquez Grand-Barachois 680942 2015 02 10

K Bourque Construction Kevin Bourque Val-d’Amour 680950 2015 02 10

Taps Art and Design Sarah Jane Homenick Sussex 680960 2015 02 11

COSTAIN’S FOOD SERVICES Matthew Costain Saint John 680961 2015 02 11

CAPITAL OVERHEAD DOOR Darren Levesque Saint John 680963 2015 02 11

Nashwaak Valley Farms Michael R.W. Sorenson Noonan 680967 2015 02 11

Vidanges J.M.Z Martine Chiasson Evangeline 680972 2015 02 11

Savoie’s BrewHouse Rodney Savoie Charlo 680973 2015 02 11

Blair Brown Painting Blair Brown Burton 680976 2015 02 11

Euston Station Charles Reid Moncton 680977 2015 02 11

ESSO PETROLEUM CANADA/PETROLES ESSO CANADA

IMPERIAL OIL/PETROLIEREIMPERIALE

Saint John 323964 2015 02 10

ESSO CHEMICAL CANADA/CHIMIE ESSO CANADA

IMPERIAL OIL/PETROLIEREIMPERIALE

Saint John 323965 2015 02 10

ESSO GAS LIQUIDS IMPERIAL OIL/PETROLIEREIMPERIALE

Saint John 324725 2015 02 10

THE AUCTION CENTER CAMERON INDUSTRIAL INC. Maugerville 332604 2015 01 29

METRO IMPERIAL OIL/PETROLIEREIMPERIALE

Moncton 332950 2015 02 10

METRO FUEL IMPERIAL OIL/PETROLIEREIMPERIALE

Saint John 332951 2015 02 10

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 17: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 223 Gazette royale — 4 mars 2015

PETROLIERE METRO IMPERIAL OIL/PETROLIEREIMPERIALE

Saint John 332952 2015 02 10

SIMHART OFFICE TECHNOLOGIES

Frances M. Hartman Riverview 335569 2015 02 06

SOLE WORKS REFLEXOLOGY Jennifer Johnson Fredericton 340622 2015 02 06

Three Apples Arts and Crafts Jennifer Klem Moncton 609349 2015 02 09

Auberge Centre-Ville Enr. 609030 N.B. Ltée Tracadie-Sheila 609636 2015 02 05

Rogersville Auto Salvage Maurice Chevarie Rogersville 609637 2015 01 29

Shiretown Image Maker W.G. Macx MacNichol Dorchester 610166 2015 02 04

PS Consulting Patricia Stafford Chamcook 615430 2015 01 29

Rick Reid Auto Glass Rick Reid Sackville 615599 2015 02 04

girvanmedia Scott Girvan Bouctouche 615832 2015 01 29

UNIQUE INTERIORS Lucie Robichaud Lower Coverdale 616557 2015 02 12

DIRECT ENERGY DIRECT ENERGY MARKETING LIMITED

Saint John 616929 2015 02 12

HYDRO-COM TECHNOLOGIES R.V. ANDERSON ASSOCIATES LIMITED

Fredericton 617181 2015 02 10

Rothesay/Quispamsis Denture Clinic Opdam Ltd. Rothesay 644120 2015 02 09

TAJA’S PROFESSIONAL GROOMING

Melissa McNulty Saint John 646600 2015 01 29

Bronzage D’Azur Mélanie Bergeron Saint-Quentin 647503 2015 02 05

DAY & ROSS TRADE NETWORKS DAY & ROSS INC. Hartland 647516 2015 01 29

IATC Marketing and Consulting Joe Russell Première nation de Tobique /Tobique First Nation

647532 2015 01 30

CENTRE AUDITIF BEAUSÉJOUR HEARING CENTER

646214 N.B. LTD. Dieppe 647733 2015 02 05

MMMuffins Threecaf Brands Canada Inc. Saint John 647740 2015 02 06

Empire Stevedoring (Maritimes) Co. FURNCAN MARINE LIMITED Saint John 647917 2015 01 30

DESIGNS WITH YOU IN MIND Kimberly Saucier Riverview 648062 2015 02 09

The Big Clean Margaret Cooper Kingston 648105 2015 02 05

Berry’s Auto & Recreation Bruce Milbury Lewis Mountain 648174 2015 01 30

Lydon Consulting Barry Lydon Fredericton 648184 2015 02 04

Résidence chêne de Mambré Les entreprises Jaccar Inc. Shediac 648206 2015 01 30

RetroReplay Jason Sussey Fredericton 648474 2015 02 05

GEG CONSULTING Garret Eugene Gesner Fredericton 648660 2015 02 11

YES! YOU CAN SING Kimberly Dayton-Lebeau Fredericton 648804 2015 02 11

Classique Hair & Innersole Reflexology by GB

Gale Barrieau Harvey Station 648841 2015 02 11

Foster & Company J. Charles FosterProfessional Corporation

Fredericton 648844 2015 02 11

Page 18: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 224 Gazette royale — 4 mars 2015

Transport Funding Canada Financial Services

VFS Canada Inc. Saint John 649304 2015 02 11

Services de financement Transport Funding Canada

VFS Canada Inc. Saint John 649327 2015 02 11

DIRECT ENERGY BUSINESS DIRECT ENERGY MARKETINGLIMITED

Saint John 649445 2015 02 12

DIRECT ENERGY HOME SERVICES

DIRECT ENERGY MARKETINGLIMITED

Saint John 649446 2015 02 12

Société internationale Veritas Acadie

David LeGallantFidèle ThériaultUlysse RobichaudPierre Benoit

Saint-Charles 650657 2015 02 05

Mister Bug (Monsieur Bibite) 651409 N.B. Inc. Saint John 652555 2015 02 05

Allie Cat Computers Frederick Craig Chase Fredericton 659678 2015 02 05

_____________________________________________________

Fredericton Mitsubishi Fredericton 647575 2015 02 12

Encadanse École de danse Rivière-à-la-Truite 670376 2015 02 05

_____________________________________________________

KYAN Construction Ryan GilliardKaleb Gilliard

Royal Road 680305 2015 01 05

Write-Click Media Stephen BelyeaJessica Shorey

Rothesay 680671 2015 01 23

A Moment in Time Special Care Home Robert ClarkJanice Comeau

Saint John 680693 2015 01 26

Northern Spirits Normand ThebeauGarland BarneyTimothy Breau

Moncton 680784 2015 01 30

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

Page 19: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 225 Gazette royale — 4 mars 2015

Ferme Alva Farm Saint-Maurice 649988 2015 02 05

MOS - MADE OF STEEL FITNESS Drummond 670752 2015 01 29

_____________________________________________________

Club ABC Angela Woodman Stéphanie MacMullin Sunzu

640087 2015 01 29

TIMKEN CANADA LP Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Servicea(NB) Inc.Saint John

617105 2015 02 09

ASIH LIMITED PARTNERSHIP Fredericton Alberta Deborah M. PowerFredericton

649299 2015 02 05

We Care Health Services LP Saint John Manitoba Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

649606 2015 01 29

Revolution ORS LP Saint John Manitoba Stewart McKelveyCorporate ServicesSaint John

680681 2015 01 26

Revolution Landfill LP Saint John Manitoba Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680682 2015 01 26

Revolution Environmental Solutions LP

Saint John Manitoba Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680683 2015 01 26

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of member-ship of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

Page 20: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 226 Gazette royale — 4 mars 2015

Revolution VSC LP Saint John Manitoba Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680684 2015 01 26

MAPLE LEAF SHORT DURATION 2015 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP

Saint John Colombie-Britannique /BritishColumbia

Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680739 2015 01 29

Imerys Canada L.P. - Imerys Canada S.E.C.

Saint John Québec / Quebec Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680742 2015 01 29

VERSACOLD LOGISTICS SERVICES

Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680768 2015 01 30

MRF 2015 Resource Limited Partnership

Saint John Alberta Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

680798 2015 02 02

_____________________________________________________

Centre Ice Retail Portfolio LP Ontario Bernard MillerMoncton

622286 2015 02 09

_____________________________________________________

TIMKEN CANADA LP Ontario Timken Canada GPULC

Saint John 617105 2015 02 09

Mill Creek Motor Freight L.P. Ontario Mill Creek MotorFreight Ltd.

Saint John 620298 2015 02 05

NORREP SHORT DURATION 2014 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP

Alberta Norrep 2014Management Inc.

Saint John 675149 2015 02 10

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limitedpartnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale aété déposée par :

ReferenceAgent and Address Number Date

Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra-provincial limited partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de changement de société en commandite ou de sociétéen commandite extraprovinciale a été déposée :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

Page 21: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 227 Gazette royale — 4 mars 2015

ARRÊTÉ XVÉleveurs de poulet du Nouveau-Brunswick

Arrêté régissant la vente de contigent1. Le présent arrêté a pour objet la mise en place d’un systèmequi permet aux détenteurs actuels de contingent de poulets devendre par encan tout ou partie de leur contingent. Il prescritégalement les renseignements requis, les délais de notificationet la marche à suivre.2. Le présent arrêté ne s’applique pas lorsque le contingent estcédé

a) à une ferme familiale incorporée dans laquelle le dé-tenteur de contingent est actionnaire actif;b) à un membre de la famille du détenteur de contingent,notamment le conjoint ou la conjointe, le fils, la fille, legendre, la bru, la belle-mère ou le beau-père; ouc) dans le cadre de la vente de l’ensemble de la fermelorsque

(i) le contingent entier du détenteur fait partie de lavente; et(ii) l’acheteur convient de produire le contingent surla ferme achetée (poulaillers) pendant cinq ans aumoins avant de le produire ailleurs et s’y engage, parécrit, auprès des Éleveurs de poulet du Nouveau-Brunswick (ÉPNB).

3. Sous réserve dea) l’article 2 du présent arrêté; etb) toute entente conclue avant l’entrée en vigueur du pré-sent arrêté, nul détenteur de contingent ne peut vendre,échanger, donner, soumettre aux enchères ou transférer detoute autre manière son contingent autrement que par l’en-tremise du processus de soumission à l’encan.

4. Un détenteur de contingent peut vendre tout ou partie deson contingent par le processus de soumission à l’encan.5. La mise à l’encan est faite au besoin. Le dernier jour ou-vrable du mois est désigné comme étant la date de l’encan. Lessoumissions sont ouvertes à midi (heure désignée) à la date dé-signée.6. Le détenteur qui souhaite vendre son contingent doit en in-former les Éleveurs de poulet du NB (EPNB) par courrier re-commandé trente (30) jours au moins avant la date du prochainencan au moyen d’un avis dans lequel sont indiqués

a) le volume du contingent à vendre; b) le prix minimum de vente, le cas échéant; et

c) toutes autres conditions de vente, sous réserve qu’ellesn’aillent pas à l’encontre du présent arrêté.

7. Les Éleveurs de poulet du NB (EPNB) doit informerl’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, les autres déten-teurs de contingent ainsi que le public en général

a) de la tenue d’une vente à l’encan;b) des renseignements contenus dans le présent arrêté; et

Ministère de l’Agriculture,de l’Aquaculture et des Pêches

ORDER XVChicken Farmers of New Brunswick

Respecting Quota Sales1. The purpose of this Order is to establish a system for theauction by existing quota holders of all or part of their chickenquota (“quota owners”), setting the information that must besupplied, notification periods and the process to be followed(the “bid auction process”).2. This Order does not apply where quota is to be transferred:

(a) To a family incorporated farm in which the quotaowner is an active shareholder;(b) To a family member of a quota owner (spouse, son,daughter, son-in-law, daughter-in-law, mother-in-law,father-in-law); or(c) As part of the sale of an entire farm operation where:

(i) The entire quota held by the quota owner is beingsold; and(ii) The purchaser agrees and undertakes in writing toChicken Farmers of New Brunswick (“CFNB”) to pro-duce quota on the purchased property (barns) for atleast 5 years before moving the quota to a new loca-tion.

3. Subject to:(a) section 2 of this Order; and(b) any agreement pre-existing this Order, a quota ownershall not sell, exchange, give, auction or otherwise transferquota other than through the bid auction process.

4. Quota owners may sell all or part of their quota through thebid auction process.5. Bid auctions will be held as required. The last businessdays in the month is designated as the bid auction date. The bidswill be opened at noon (the “designated time”) on each bid auc-tion date.6. A quota owner wishing to sell quota will advise CFNB byregistered mail at least 30 days prior to the next auction date.The notice will include the following information:

(a) Amount of quota to be sold;(b) The minimum asking price (the “minimum price”), ifany; and(c) Any other conditions to the auction imposed by thequota owner that are not in conflict with this Order.

7. CFNB will inform the Agricultural Alliance of NewBrunswick, existing quota holders and the public:

(a) That a quota auction will occur;(b) Of the information provided for in this Order; and

Department of Agriculture,Aquaculture and Fisheries

Page 22: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 228 Gazette royale — 4 mars 2015

(c) That bids must be submitted to CFNB at least 10 daysbefore the auction date, as per sections 8. 9 and 10.

8. To qualify as a quota holder, bidders must either be existingquota holders, or be able to demonstrate adequate education,training and experience to:

(a) provide the animal husbandry needed for health andproductivity of the flock,(b) plan and manage a viable chicken production businessas a part of an existing farm operation or as a stand-aloneenterprise, and(c) carry out good farming practices that comply with allregulations pertaining to the OFFSAP and Animal CareProgram (“qualified bidders”).

9. A party wishing to bid for the quota must submit:(a) A confidential bid for the quota to be auctioned, sentby registered letter and received by Chicken Farmers ofNew Brunswick, 277 Main Street, Suite 103, Fredericton,NB, E3A 1E1, no later than 10 clear days before the auc-tion date;(b) And where the bidder is not already a quota holder, ev-idence that the bidder is a qualified bidder as described insection 8.

10. Confidential bids must be sealed and accompanied with anon-refundable 10% deposit of the proposed purchase price, bycertified cheque payable to the seller.11. The confidential bids will be opened on the bid auctiondate, at designated time, by CFNB staff and staff of the account-ing firm or legal firm used by CFNB.

12. Bid openings will be open to the public.13. To be successful, a bid must:

(a) Meet or exceed the minimum price, if one was set;

(b) Comply with Provincial orders, regulations and theNB Natural Products Act, and(c) Comply with Federal Legislation; and(d) Come from a qualified bidder.

14. The highest qualified bidder or, where a minimum pricewas set, the qualified bidder who offers the highest price thatmeets or exceeds the minimum price, shall be awarded thequota. Where two or more qualified bidders have submitted thesame highest price, the quota shall be divided in equal sharesbetween them.15. If no qualified bidder meets the minimum price, the quotaowner may either:

(a) Withdraw the quota from the auction; or

(b) Sell the quota to the highest qualified bidder, if a qual-ified bidder has bid. Where two or more qualified biddershave submitted the same highest price that the quota owneris prepared to accept, the quota shall be divided in equalshares between them.

16. The quota owner and the successful bidder will discuss thesteps to complete the transfer.

17. Deposit cheques will be returned to unsuccessful bidders.

c) de l’obligation de soumettre les offres dix jours ou-vrables au moins avant la date de l’encan, conformémentaux articles 8, 9 et 10.

8. Peuvent détenir un contingent seuls les soumissionnairesqui sont déjà détenteurs de contingent ou qui démontrent avoirl’éducation, la formation et l’expérience nécessaires pour

a) assurer un élevage sein et productif du troupeau;

b) planifier et gérer une production viable de poulet dansle cadre d’une exploitation agricole existante ou dans uneentreprise autonome; etc) assurer de bonnes pratiques d’élevage, conformes àl’ensemble de la réglementation régissant le PASAF et leProgramme de soins aux animaux.

9. Quiconque souhaite participer à l’encan doita) faire parvenir une soumission confidentielle par cour-rier recommandé au bureau des Éleveurs de poulet du NBau 277, rue Main, Suite 103, Fredericton, NB, E3A 1E1 auplus tard dix jours ouvrables avant la date de l’encan; et

b) fournir la preuve qu’il est un soumissionnaire admis-sible au titre de l’article 8, dans le cas où elle n’est pas déjàdétenteur de contingent.

10. La soumission doit être scellée et accompagnée d’un dépôtcorrespondant à 10% du prix d’achat proposé. Le chèque certi-fié doit être établi à l’ordre du vendeur.11. L’ouverture des soumissions se fait à la date de l’encan àl’heure désignée par le personnel des EPNB, en présence demembres du cabinet comptable ou cabinet d’avocats retenu parles EPNB.12. Le public peut participer à l’ouverture des soumissions.13. Pour être acceptée, la soumission doit

a) correspondre au prix minimum demandé, le caséchéant ou le dépasser;b) être conforme aux arrêtés et règlements provinciauxainsi qu’à la Loi sur les produits naturels du NB;c) être conforme à la législation fédérale; etd) provenir d’un soumissionnaire admissible.

14. Le contingent est adjugé au plus haut soumissionnaire ou,dans le cas où un prix minimum est demandé, au soumission-naire qui a fait l’offre la plus élevée ou supérieure au prix mini-mum. Lorsque deux ou plusieurs soumissionnaires font lamême offre au montant supérieur à celui demandé, le contingentdoit être réparti également entre eux.15. Dans le cas où aucune offre ne satisfait au prix minimumdemandé, le détenteur du contingent peut

a) retirer le contingent du processus de vente à l’encan;oub) vendre le contingent au plus offrant; dans le cas oùdeux ou plusieurs soumissionnaires admissibles font lamême offre, le contingent doit être réparti également entreeux.

16. Le détenteur du contingent et le soumissionnaire retenu dé-cident entre eux des étapes à suivre pour la conclusion du trans-fert.17. Les chèques de garantie sont retournés aux soumission-naires non retenus.

Page 23: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 229 Gazette royale — 4 mars 2015

18. The quota exchange will occur when legal documents areobtained by CFNB and the CFNB board of directors has ap-proved the transfer.19. This order comes into force February 2, 2015.

Marc Cormier Louis MartinChairman Manager

Public notice of change of registered nameunder the Change of Name Act, chapter C-2.001,

ss.9(1.1) of the Acts of New Brunswick, 1987

Previous Registered Name: Margaret Ann NashNew Registered Name: Peggy NashAddress: Maquapit Lake, NBDate Granted: March 25, 2014

Previous Registered Name: Rianne Elizabeth LodgeNew Registered Name: Reid Everard LodgeAddress: Fredericton, NBDate Granted: March 25, 2014

Previous Registered Name: Andrew David John SchnerchNew Registered Name: Andrew John KellyAddress: Riverview, NBDate Granted: April 14, 2014

Previous Registered Name: Eric Gregory Gallant-MunroeNew Registered Name: Eric Gregory MunroeAddress: Moncton, NBDate Granted: April 15, 2014

Previous Registered Name: Randy Joseph BrownNew Registered Name: Randall William AveryAddress: Saint John, NBDate Granted: May 9, 2014

Previous Registered Name: Billy Joseph BernardNew Registered Name: Billy Joseph LeBlancAddress: Sainte-Marie-de-Kent, NBDate Granted: May 14, 2014

Previous Registered Name: William Stephen JohnVan Eden Glendenning

New Registered Name: William John O’NeilAddress: Fredericton, NBDate Granted: May 20, 2014

Previous Registered Name: Gnonsiekemon Ali FarkaNew Registered Name: Gnonsiekemon Lehou LehouAddress: Fredericton, NBDate Granted: May 21, 2014

Josée DubéRegistrar General of Vital Statistics

Service New Brunswick

18. L’échange du contingent se fait sur réception par les EPNBdes documents légaux et après approbation du transfert par sonconseil d’administration.19. Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 2015.

Le président, Le secrétaire gestionnaire,Marc Cormier Louis Martin

Avis public de changement de noms enregistrés enapplication de la Loi sur le changement de nom, lois du

Nouveau-Brunswick de 1987, c.C-2.001, par.9(1.1)

Ancien nom enregistré : Margaret Ann NashNouveau nom enregistré : Peggy NashAdresse : Maquapit Lake (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 25 mars 2014

Ancien nom enregistré : Rianne Elizabeth LodgeNouveau nom enregistré : Reid Everard LodgeAdresse : Fredericton (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 25 mars 2014

Ancien nom enregistré : Andrew David John SchnerchNouveau nom enregistré : Andrew John KellyAdresse : Riverview (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 14 avril 2014

Ancien nom enregistré : Eric Gregory Gallant-MunroeNouveau nom enregistré : Eric Gregory MunroeAdresse : Moncton (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 15 avril 2014

Ancien nom enregistré : Randy Joseph BrownNouveau nom enregistré : Randall William AveryAdresse : Saint John (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 9 mai 2014

Ancien nom enregistré : Billy Joseph BernardNouveau nom enregistré : Billy Joseph LeBlancAdresse : Sainte-Maire-de-Kent (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 14 mai 2014

Ancien nom enregistré : William Stephen JohnVan Eden Glendenning

Nouveau nom enregistré : William John O’NeilAdresse : Fredericton (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 20 mai 2014

Ancien nom enregistré : Gnonsiekemon Ali FarkaNouveau nom enregistré : Gnonsiekemon Lehou LehouAdresse : Fredericton (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 21 mai 2014

Josée DubéRegistraire générale des statistiques

de l’état civil

Services Nouveau-Brunswick

Page 24: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 230 Gazette royale — 4 mars 2015

NOTICE OF RULEThe repeal and replacement of National Instrument 51-102Continuous Disclosure Obligations (the Instrument) and Com-panion Policy 51-102CP Continuous Disclosure Obligations(the Policy).

Ministerial ConsentOn 10 February 2015, the Minister of Justice consented to themaking of the above-noted amendments.

Summary of AmendmentsThe repeal and replacement of the rule is intended to harmonizethe contents of the rule and provide public access to the most re-cent version of the rule currently in force within the CanadianSecurities Administrators.

Effective DateThe amendments came into force in New Brunswick on 19 Feb-ruary 2015.

How to Obtain a CopyThe text of the above-noted amendments can be obtained fromthe Commission’s website: http://www.fcnb.ca

Paper copies may be obtained from the Commission by writing,telephoning or e-mailing:

SecretaryFinancial and Consumer Services Commission85 Charlotte Street, Suite 300Saint John, N.B. E2L 2J2Telephone: 506-658-3060Toll Free: 866-933-2222 (within NB only)Fax: 506-658-3059E-mail: [email protected]

________________

Notice under the Co-operative Associations ActNotice is hereby given pursuant to subsection 44(4) of the Co-operative Associations Act, that the name CanAtlantic DairyCo-operative Ltd. has been struck off the register and the asso-ciation dissolved as of February 28th, 2015.

Claire GagnonRegistrar of Co-operatives

Financial and Consumer Services Commission

AVIS DE RÈGLEAbrogation et remplacement de la Norme canadienne 51-102sur les obligations d’information continue (la « règle ») et l’Ins-truction complémentaire relative à la Norme canadienne 51-102sur les obligations d’information continue (l’« instruction com-plémentaire »).

Consentement ministérielLe 10 février 2015, le ministre de la Justice a donné son consen-tement à l’établissement des modifications énoncées ci-dessus.

Résumé des modificationsL’abrogation et le remplacement de la règle visent à harmoniserle contenu de la règle, et à permettre au public d’avoir accès àla plus récente version de la règle présentement en vigueur ausein des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Date d’entrée en vigueurLes modifications sont entrées en vigueur au Nouveau-Brunswick le 19 février 2015.

Comment obtenir un exemplaireOn trouvera le texte des modifications énoncées ci-dessus parl’entremise du site web de la Commission : http://www.fcnb.ca

On peut se procurer un exemplaire sur papier du document encommuniquant par courrier, par téléphone ou par courriel avecla Commission, dont voici les coordonnées :

SecrétaireCommission des services financiers et des services aux consommateurs85, rue Charlotte, bureau 300Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2Téléphone : 506-658-3060Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement)Télécopieur : 506-658-3059Courriel : [email protected]

________________

Avis en vertu de la Loi sur les associations coopérativesSachez, en vertu du paragraphe 44(4) de la Loi sur les associa-tions coopératives, que le nom CanAtlantic Dairy Co-operativeLtd. a été radié et que l’association est ainsi dissoute le 28 fé-vrier 2015.

Claire GagnonRegistraire des coopératives

Commission des services financiers et des services

aux consommateurs

Page 25: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 231 Gazette royale — 4 mars 2015

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Kelly Margaret Thibodeau, original Mortgagor; StephaneThibodeau, Spouse of Kelly Margaret Thibodeau; and to all oth-ers whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mort-gage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts inamendment thereof. Freehold property being situated at 125Ketepec Road, Saint John, New Brunswick, the same lot con-veyed to Kelly Margaret Thibodeau by Transfer registered inthe Land Titles Office on October 1, 2009 as document number27832444.

Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held at theSaint John Court House located at 10 Peel Plaza, Saint John,New Brunswick, on the 20th day of March, 2015, at the hour of11:15 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale inthe Telegraph-Journal dated February 19, February 26, March5 and March 12, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: AdelGönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Brent Albert Miles, original Mortgagor; and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 700 UnionStreet, Unit 208, Fredericton, New Brunswick, the same lotconveyed to Brent Albert Miles by Transfer registered in theLand Titles Office on May 27, 2013, as document number32697659.

Notice of Sale given by Bank of Montreal as Mortgagee. Sale tobe held at the offices of the Fredericton Court House, 427Queen Street, Fredericton, New Brunswick on the 17th day ofMarch, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See adver-tisement of Notice of Sale in The Daily Gleaner dated February18, February 25, March 4 and March 11, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: AdelGönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Notices of Sale

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Kelly Margaret Thibodeau, débitrice hypothé-caire originaire; Stephane Thibodeau, conjoint de KellyMargaret Thibodeau; et tout autre intéressé éventuel. Vente ef-fectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de laLoi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, et des lois qui la mo-difient. Biens en tenure libre situés au 125, chemin Ketepec, àSaint John (Nouveau-Brunswick), et correspondant au mêmelot ayant été transféré à Kelly Margaret Thibodeau par l’acte detransfert enregistré au bureau d’enregistrement foncier le 1er oc-tobre 2009, sous le numéro 27832444.Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente auralieu le 20 mars 2015, à 11 h 15, heure locale, au palais de justicede Saint John, 10, place Peel, Saint John (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 19 et 26 février etdes 5 et 12 mars 2015 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Montréal, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, 644, rueMain, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataire : Brent Albert Miles, débiteur hypothécaire origi-naire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertudes dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur lesbiens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, et des lois qui la modifient.Biens en tenure libre situés au 700, rue Union, unité 208, àFredericton (Nouveau-Brunswick), et correspondant au mêmelot ayant été transféré à Brent Albert Miles par l’acte de trans-fert enregistré au bureau d’enregistrement foncier le 27 mai2013, sous le numéro 32697659.Avis de vente donné par la Banque de Montréal, créancière hy-pothécaire. La vente aura lieu le 17 mars 2015, à 11 h, heurelocale, au palais de justice de Fredericton, 427, rue Queen,Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiéedans les éditions des 18 et 25 février et des 4 et 11 mars 2015 duDaily Gleaner.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Montréal, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, 644, rueMain, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Avis de vente

Page 26: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 232 Gazette royale — 4 mars 2015

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Daniel Eric LeBlanc, Joseph Claude LeBlanc, DellaLeBlanc, and Marie Cecile LeBlanc, Mortgagors and owners ofthe equity of redemption; and all others whom it may concern.Sale under the terms of the mortgage and the Property Act,R.S.N.B. 1973, c.P-19. Freehold property situate at90 Emmanuel Street, Dieppe, Province of New Brunswick, thesaid land corresponding to the same lot having been conveyedto Daniel Eric LeBlanc, Joseph Claude LeBlanc, DellaLeBlanc, and Marie Cecile LeBlanc by deed registered at theRegistry Office as Number 30229695.

Notice of sale given by Scotia Mortgage Corporation, Mort-gagee. Sale on March 17, 2015, at 11:00 a.m., local time, atMoncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, NewBrunswick. See Notice of Sale in the February 19 and 26, andMarch 5 and 12, 2015, editions of L’Acadie Nouvelle.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,per Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, SuiteS400, P.O. Box 1368, Moncton, NB E1C 8T6, telephone: 506-857-8970, fax: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Wayne Gregory Beaman, original Mortgagor; and to all oth-ers whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mort-gage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts inamendment thereof. Freehold property being situated at38 Dayton Court, Riverview, New Brunswick, the same lot con-veyed to Wayne Gregory Beaman by Transfer registered in theLand Titles office on November 22, 2006, as document number23106033.

Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia. Sale to beheld at Moncton City Hall located at 655 Main Street, Moncton,New Brunswick, on the 17th day of March, 2015, at the hour of11:15 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale inthe Times & Transcript dated February 19, February 26, March5 and March 12, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele-phone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Todd William Hackett and Wendy Lynn Hackett, originalMortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursu-ant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B.,1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold propertybeing situated at 172 Thibodeau Street, Dieppe, NewBrunswick, the same lot conveyed to Todd William Hackett andWendy Lynn Hackett by Deed registered in the Westmorland

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : Daniel Eric LeBlanc, Joseph Claude LeBlanc,Della LeBlanc, Marie Cecile LeBlanc, débiteurs hypothécaireset propriétaires du droit de rachat; et tout autre intéressé éven-tuel. Vente effectuée conformément aux dispositions de l’acted’hypothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19.Biens en tenure libre situés au 90, rue Emmanuel, Dieppe, pro-vince du Nouveau-Brunswick, lesdits biens correspondant aumême lot ayant été transféré à Daniel Eric LeBlanc, JosephClaude LeBlanc, Della LeBlanc, Marie Cecile LeBlanc parTransfert enregistré au bureau d’enregistrement foncier sous lenuméro 30229695.Avis de vente donné par la Société Hypothécaire Scotia, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 17 mars 2015 à 11 h,heure locale, à l’Hôtel de ville de Moncton, situé au 655, rueMain, Moncton (Nouveau-Brunswick). Voir l’avis de vente pu-blié dans les éditions L’Acadie Nouvelle du 19 février, 26 fé-vrier, 5 mars et 12 mars 2015.

McInnes Cooper, avocats de la Société Hypothécaire Scotia,par Adel Gönczi, Centre Croix Bleue, 644, rue Main, PièceS400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6,téléphone : 506-857-8970, télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataire : Wayne Gregory Beaman, débiteur hypothécaireoriginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée envertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur lesbiens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, et des lois qui la modifient.Biens en tenure libre situés au 38, cour Dayton, à Riverview(Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant ététransféré à Wayne Gregory Beaman par l’acte de transfert enre-gistré au bureau d’enregistrement foncier le 22 novembre 2006,sous le numéro 23106033.Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse. Lavente aura lieu le 17 mars 2015, à 11 h 15, heure locale, à l’hôtelde ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 19 et26 février et des 5 et 12 mars 2015 du Times & Transcript.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, bureau S400,644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Todd William Hackett et Wendy Lynn Hackett,débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éven-tuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, et deslois qui la modifient. Biens en tenure libre situés au 172, rueThibodeau, à Dieppe (Nouveau-Brunswick), et correspondantau même lot ayant été transféré à Todd William Hackett et

Page 27: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 233 Gazette royale — 4 mars 2015

County Registry Office on December 1, 1995, in Book 2409, atPage 394, as document number 615107.

Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held atMoncton City Hall located at 655 Main Street, Moncton, NewBrunswick, on the 17th day of March, 2015, at the hour of 11:30a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in theTimes & Transcript dated February 19, February 26, March 5and March 12, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: AdelGönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Joshua Claude Pitre and Renee Pitre, original Mortgagors;and to all others whom it may concern. Sale pursuant to termsof the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19and Acts in amendment thereof. Freehold property being situ-ated at 31 Carleton Drive, Quispamsis, New Brunswick, thesame lot conveyed to Joshua Claude Pitre and Renee Pitre byTransfer registered in the Land Titles Office on January 10,2014 as document number 33467532.

Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia. Sale to beheld at the Saint John Court House located at 10 Peel Plaza,Saint John, New Brunswick, on the 20th day of March, 2015, atthe hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Noticeof Sale in the Telegraph-Journal dated February 19, February26, March 5 and March 12, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele-phone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: the Estate of Dorothy Ruth Rabaey, original Mortgagor; tothe Estate of Camiel Maurice Rabaey, original Spouse of Mort-gagor; and to all others whom it may concern. Sale pursuant toterms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973,c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property beingsituated at 16 McBrine Road, Douglas, New Brunswick, thesame lot conveyed to Dorothy Ruth Rabaey by Transfer regis-tered in the Land Titles System on August 12, 1988, as docu-ment number 314173 and to Camiel Maurice Rabaey by Trans-fer registered in the Land Titles System on December 6, 2006 asdocument number 2317740.

Wendy Lynn Hackett par l’acte de transfert enregistré au bureaude l’enregistrement du comté de Westmorland le 1er décembre1995, sous le numéro 615107, à la page 394 du registre 2409.Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente auralieu le 17 mars 2015, à 11 h 30, heure locale, à l’hôtel de villede Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 19 et 26 février etdes 5 et 12 mars 2015 du Times & Transcript.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Montréal, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, 644, rueMain, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Joshua Claude Pitre et Renee Pitre, débiteurs hy-pothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel. Venteeffectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et dela Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, et des lois qui lamodifient. Biens en tenure libre situés au 31, promenadeCarleton, à Quispamsis (Nouveau-Brunswick), et correspon-dant au même lot ayant été transféré à Joshua Claude Pitre etRenee Pitre par l’acte de transfert enregistré au bureau d’enre-gistrement foncier le 10 janvier 2014, sous le numéro33467532.Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse. Lavente aura lieu le 20 mars 2015, à 11 h, heure locale, au palaisde justice de Saint John, 10, place Peel, Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 19 et26 février et des 5 et 12 mars 2015 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, bureau S400,644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : La succession de Dorothy Ruth Rabaey, débi-trice hypothécaire originaire; la succession de Camiel MauriceRabaey, conjoint de la débitrice hypothécaire originaire; et toutautre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des disposi-tions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B.1973, c.P-19, et des lois qui la modifient. Biens en tenure libresitués au 16, chemin McBrine, à Douglas (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré àDorothy Ruth Rabaey par l’acte de transfert enregistré dans lesystème d’enregistrement foncier le 12 août 1988, sous le nu-méro 314173, et ayant été transféré à Camiel Maurice Rabaeypar l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistre-ment foncier le 6 décembre 2006, sous le numéro 2317740.

Page 28: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 234 Gazette royale — 4 mars 2015

Notice of Sale given by Bank of Nova Scotia as Mortgagee.Sale to be held at the Fredericton Justice Building located at 427Queen Street, Fredericton, New Brunswick on the 19th day ofMarch, 2015, at the hour of 11:15 a.m., local time. See adver-tisement of Notice of Mortgage Sale in The Daily Gleaner datedFebruary 18, February 25, March 4 and March 11, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Nova Scotia, Per: AdelGönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

TO: LÉON MAZEROLLE and NANCY ROY MAZEROLLEof Dunlop, in the County of Gloucester and Province of NewBrunswick, Mortgagors and holders of the Equity of Redemp-tion; GRANT THORNTON POIRIER LIMITED (formerlyA.C. Poirier & Associates Inc), trustee in bankruptcy of LéonMazerolle (alias Léon Mazerolle Junior); CAISSE POPU-LAIRE CHALEUR LTÉE/CHALEUR CREDIT UNION LTD,holder of the mortgage; AND ALL OTHER WHOM IT MAYCONCERN.Freehold property located at 1673 Carleton Street, in Dunlop,County of Gloucester, Province of New Brunswick, designatedby property identification number 20285078 and property ac-count number 03144968.Notice of Sale given by CAISSE POPULAIRE CHALEURLTÉE/CHALEUR CREDIT UNION LTD, Mortgagee, underthe Power of Sale contained in the mortgage and s.44 of theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, and amendments thereto.

Sale to be held on March 23rd, 2015, at 9:30 a.m., local time, atthe Gloucester County Court House at 254 St Patrick Street,Bathurst, New Brunswick. See advertisement in L’AcadieNouvelle.

Robert M. Boudreau, Solicitor for La Caisse Populaire ChaleurLtée/Chaleur Credit Union Ltd

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, LegislativeServices, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Royal GazetteCoordinator may refuse to publish a document if any part of itis illegible, and may delay publication of any document for ad-ministrative reasons.

Notice to Advertisers

Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 19 mars 2015, à11 h 15, heure locale, au palais de justice de Fredericton,427, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’an-nonce publiée dans les éditions des 18 et 25 février et des 4 et11 mars 2015 du Daily Gleaner.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, bureau S400,644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

DESTINATAIRES : LÉON MAZEROLLE et NANCY ROYMAZEROLLE de Dunlop dans le comté de Gloucester et laprovince du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires etpropriétaire du droit de rachat; GRANT THORNTONPOIRIER LIMITED (anciennement A.C. Poirier & AssociatesInc), syndic de la faillite de Léon Mazerolle (alias LéonMazerolle Junior); CAISSE POPULAIRE CHALEUR LTÉE/CHALEUR CREDIT UNION LTD, titulaire de l’hypothèque;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Bien en tenure libre situé au 1673, rue Carleton à Dunlop, comtéde Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, désigné par lenuméro d’identification de propriété 20285078 et le numéro decompte des biens 03144968.Avis de vente donné par LA CAISSE POPULAIRE CHA-LEUR LTÉE/CHALEUR CREDIT UNION LTD, créancièrehypothécaire, en vertu du pouvoir de vente contenu dans l’acted’hypothèque et de l’article 44 de la Loi sur les biens,L.R.N.-B., 1973, c.P-19, et ses modifications.La vente aura lieu le 23 mars 2015 à 9 h 30 de l’avant-midi,heure locale, au palais de justice du comté de Gloucester situéau 254, rue St Patrick, Bathurst (Nouveau-Brunswick). Voirl’annonce publiée dans L’Acadie Nouvelle.

Robert M. Boudreau, avocat de la Caisse Populaire ChaleurLtée/Chaleur Credit Union Ltd

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept joursavant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparéde la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivreimmédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazetteroyale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi-sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-ministratives.

Avis aux annonceurs

Page 29: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 235 Gazette royale — 4 mars 2015

Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney_general/royal_gazette.html

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of CourtNote: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (àl’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/gazette_royale.html

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédureNota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po

sur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

Page 30: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 236 Gazette royale — 4 mars 2015

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plusshipping and handling where applicable.

Legislative ServicesOffice of the Attorney General

Chancery Place675 King StreetP.O. Box 6000

Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-8372E-mail: [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette andleft with the Commissionaire.

Statutory Orders and Regulations Part II

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, à l’adresse suivante, pour la somme de 4 $ l’exem-plaire, plus la taxe de 5 %, ainsi que les frais applicables deport et de manutention.

Services législatifsCabinet du procureur général

Place Chancery675, rue King

C.P. 6000Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tél. : 506-453-8372Courriel : [email protected]

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doitêtre remise au commissionnaire.

Ordonnances statutaires et Règlements Partie II

Page 31: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 237 Gazette royale — 4 mars 2015

NEW BRUNSWICKREGULATION 2015-1

under the

RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2015-1

pris en vertu de la

PRESCRIPTION DRUG PAYMENT ACT(O.C. 2015-19)

LOI SUR LA GRATUITÉ DES MÉDICAMENTSSUR ORDONNANCE

(D.C. 2015–19)

Filed February 23, 2015 Déposé le 23 février 2015

1 Section 15 of New Brunswick Regulation 84-170under the Prescription Drug Payment Act is amended

1 L’article 15 du Règlement du Nouveau-Brunswick84-170 pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médi-caments sur ordonnance est modifié

(a) by adding after subsection (1) the following: a) par l’adjonction de ce qui suit après le para-graphe (1) :

15(1.1) Nothing in this section prevents a participatingprovider from refunding a beneficiary the amount, or aportion of the amount, referred to in subsection (1).

15(1.1) Rien au présent article n’empêche le dispensa-teur participant de rembourser au bénéficiaire l’intégrali-té ou une partie du montant que prévoit le para-graphe (1).

(b) by repealing subsection (2) and substituting thefollowing:

b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem-placement par ce qui suit :

15(2) If a beneficiary makes a claim against the pro-gramme under section 14, an amount equal to theamount required to be charged under subsection (1) foreach entitled service shall be deducted from the amountof the reimbursement, if any.

15(2) Si le bénéficiaire demande un remboursement aurégime en application de l’article 14, un montant équiva-lant à celui exigé en application du paragraphe (1) pourchaque service assuré est déduit du montant du rembour-sement, le cas échéant.

Page 32: The Royal Gazette / Gazette royale (15/03/04)The Royal Gazette — March 4, 2015 208 Gazette royale — 4 mars 2015 FEBRUARY 5, 2015 2015-15 Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act,

The Royal Gazette — March 4, 2015 238 Gazette royale — 4 mars 2015

NEW BRUNSWICKREGULATION 2015-2

under the

RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2015-2

pris en vertu de la

PRESCRIPTION AND CATASTROPHIC DRUGINSURANCE ACT

(O.C. 2015-20)

LOI SUR L’ASSURANCE MÉDICAMENTS SURORDONNANCE ET MÉDICAMENTS ONÉREUX

(D.C. 2015-20)

Filed February 23, 2015 Déposé le 23 février 2015

1 Section 14 of New Brunswick Regulation 2014-27under the Prescription and Catastrophic Drug Insur-ance Act is amended by adding after subsection (9) thefollowing:

1 L’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick2014-27 pris en vertu de la Loi sur l’assurance médica-ments sur ordonnance et médicaments onéreux est mo-difié par l’adjonction de ce qui suit après le para-graphe (9) :

14(10) Nothing in this section prevents a participatingprovider from refunding a member of the Plan theamount, or a portion of the amount, referred to in sub-section (7), (8) or (9).

14(10) Rien au présent article n’empêche le dispensa-teur participant de rembourser au membre du régimel’intégralité ou une partie du montant que prévoit le pa-ragraphe (7), (8) ou (9).

2 Paragraph 21(1)(h) of the Regulation is repealedand the following is substituted:

2 L’alinéa 21(1)h) du Règlement est abrogé et rem-placé par ce qui suit :

(h) the amount of the co-payment under subsection14(7), (8) or (9);

h) le montant de la quote-part que prévoit le para-graphe 14(7), (8) ou (9);

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved/Tous droits réservés