22
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 175 Wednesday, January 25, 2017 / Le mercredi 25 janvier 2017 91 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette coordinator no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the coordinator. DECEMBER 15, 2016 2016-311 1. Under subsections 2(2) and 3(2) of the Assessment and Planning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governor in Coun- cil appoints Terrence Lenihan, Bathurst, New Brunswick, as Vice-Chair of the Assessment and Planning Appeal Board, for a term of five years, effective December 15, 2016. 2. Under paragraph 2(1)(b) and subsection 3(3) of the Assess- ment and Planning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Clement Tremblay, Dalhousie, New Bruns- wick, as a member of the Assessment and Planning Appeal Orders in Council Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale comme soumis. Les documents à publier doivent parvenir au coordonna- teur de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou- vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec le coordonnateur. LE 15 DÉCEMBRE 2016 2016-311 1. En vertu des paragraphes 2(2) et 3(2) de la Loi sur la Com- mission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Terrence Lenihan, de Bathurst (Nouveau-Brunswick), vice-président de la Commis- sion d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, pour un mandat de cinq ans, à compter du 15 décembre 2016. 2. En vertu de l’alinéa 2(1)b) et du paragraphe 3(3) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urba- nisme, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Clément Tremblay, de Dalhousie (Nouveau-Brunswick), Décrets en conseil

The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

  • Upload
    others

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 175 Wednesday, January 25, 2017 / Le mercredi 25 janvier 2017 91

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette coordinator no later than noon, at least7 working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe coordinator.

DECEMBER 15, 20162016-311

1. Under subsections 2(2) and 3(2) of the Assessment andPlanning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governor in Coun-cil appoints Terrence Lenihan, Bathurst, New Brunswick, asVice-Chair of the Assessment and Planning Appeal Board, fora term of five years, effective December 15, 2016.

2. Under paragraph 2(1)(b) and subsection 3(3) of the Assess-ment and Planning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governorin Council appoints Clement Tremblay, Dalhousie, New Bruns-wick, as a member of the Assessment and Planning Appeal

Orders in Council

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale comme soumis.

Les documents à publier doivent parvenir au coordonna-teur de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou-vrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec le coordonnateur.

LE 15 DÉCEMBRE 20162016-311

1. En vertu des paragraphes 2(2) et 3(2) de la Loi sur la Com-mission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme Terrence Lenihan, deBathurst (Nouveau-Brunswick), vice-président de la Commis-sion d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, pour unmandat de cinq ans, à compter du 15 décembre 2016.2. En vertu de l’alinéa 2(1)b) et du paragraphe 3(3) de la Loisur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urba-nisme, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeClément Tremblay, de Dalhousie (Nouveau-Brunswick),

Décrets en conseil

Page 2: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017

Board, representing Region Five, for a term of three years, ef-fective December 15, 2016.

3. Under subsections 3(3) and 9(1) of the Assessment andPlanning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governor in Coun-cil appoints May Nazair, Campbellton, New Brunswick, as analternate member of the Assessment and Planning AppealBoard, representing Region Five, for a term of three years, ef-fective December 15, 2016.

4. Under paragraph 2(1)(b) and subsection 3(3) of the Assess-ment and Planning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governorin Council appoints Kayleigh Blacklock, Saint John, NewBrunswick, as a member of the Assessment and Planning Ap-peal Board, representing Region Six, for a term of three years,effective December 15, 2016.

5. Under paragraph 2(1)(b) and subsection 3(3) of the Assess-ment and Planning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governorin Council appoints R. Scott Wilson, Saint John, New Bruns-wick, as a member of the Assessment and Planning AppealBoard, representing Region Six, for a term of three years, effec-tive December 15, 2016.

6. Under paragraph 2(1)(b) and subsection 3(3) of the Assess-ment and Planning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governorin Council appoints Linda J. Watson, Springfield, New Bruns-wick, as a member of the Assessment and Planning AppealBoard, representing Region Seven, for a term of three years, ef-fective December 15, 2016.

7. Under subsections 3(3) and 9(1) of the Assessment andPlanning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governor in Coun-cil appoints Karen L. Chantler, Apohaqui, New Brunswick, asan alternate member of the Assessment and Planning AppealBoard, representing Region Seven, for a term of three years, ef-fective December 15, 2016.

8. Under paragraph 2(1)(b) and subsection 3(3) of the Assess-ment and Planning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governorin Council appoints Korey Jennings, Fredericton, New Bruns-wick, as a member of the Assessment and Planning AppealBoard, representing Region Nine, for a term of three years, ef-fective December 15, 2016.

9. Under subsections 3(3) and 9(1) of the Assessment andPlanning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governor in Coun-cil appoints Giselle Price, Fredericton, New Brunswick, as analternate member of the Assessment and Planning AppealBoard, representing Region Nine, for a term of three years, ef-fective December 15, 2016.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

membre de la Commission d’appel en matière d’évaluation etd’urbanisme représentant la région cinq, pour un mandat detrois ans, à compter du 15 décembre 2016.3. En vertu des paragraphes 3(3) et 9(1) de la Loi sur la Com-mission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme May Nazair, deCampbellton (Nouveau-Brunswick), membre remplaçante de laCommission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme re-présentant la région cinq, pour un mandat de trois ans, à comp-ter du 15 décembre 2016.4. En vertu de l’alinéa 2(1)b) et du paragraphe 3(3) de la Loisur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urba-nisme, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeKayleigh Blacklock, de Saint John (Nouveau-Brunswick),membre de la Commission d’appel en matière d’évaluation etd’urbanisme représentant la région six, pour un mandat detrois ans, à compter du 15 décembre 2016.5. En vertu de l’alinéa 2(1)b) et du paragraphe 3(3) de la Loisur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urba-nisme, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeR. Scott Wilson, de Saint John (Nouveau-Brunswick), membrede la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urba-nisme représentant la région six, pour un mandat de trois ans, àcompter du 15 décembre 2016.6. En vertu de l’alinéa 2(1)b) et du paragraphe 3(3) de la Loisur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urba-nisme, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeLinda J. Watson, de Springfield (Nouveau-Brunswick),membre de la Commission d’appel en matière d’évaluation etd’urbanisme représentant la région sept, pour un mandat detrois ans, à compter du 15 décembre 2016.7. En vertu des paragraphes 3(3) et 9(1) de la Loi sur la Com-mission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme Karen L. Chantler,d’Apohaqui (Nouveau-Brunswick), membre remplaçante de laCommission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme re-présentant la région sept, pour un mandat de trois ans, à comp-ter du 15 décembre 2016.8. En vertu de l’alinéa 2(1)b) et du paragraphe 3(3) de la Loisur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urba-nisme, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeKorey Jennings, de Fredericton (Nouveau-Brunswick),membre de la Commission d’appel en matière d’évaluation etd’urbanisme représentant la région neuf, pour un mandat detrois ans, à compter du 15 décembre 2016.9. En vertu des paragraphes 3(3) et 9(1) de la Loi sur la Com-mission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme Giselle Price, deFredericton (Nouveau-Brunswick), membre remplaçante de laCommission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme re-présentant la région neuf, pour un mandat de trois ans, à comp-ter du 15 décembre 2016.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

Page 3: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 93 Gazette royale — 25 janvier 2017

OCTOBER 5, 20162016-252

Under subsection 10(1) of the Unsightly Premises Act, theLieutenant-Governor in Council suspends the operation of sec-tions 4 to 7, 18, 19 and 20 of the Unsightly Premises Act in thefollowing communities:

(a) Kedgwick;(b) Village of McAdam;(c) Neguac;(d) Saint-Louis de Kent; and(e) Village de St. Hilaire.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

DECEMBER 15, 20162016-316

Under section 12 of the Public Works Act, the Lieutenant-Governor in Council gives approval for the Minister of Trans-portation and Infrastructure to convey the property described inSchedule “A” hereto attached, known as the former FrancesMullin Property, 615 Ready Street, Saint John, New Brunswick,to Donald A. Matheson, Saint John, New Brunswick, for thepurchase price of $10,000.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

LE 5 OCTOBRE 20162016-252

En vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les lieux inesthé-tiques, le lieutenant-gouverneur en conseil suspend l’applica-tion des articles 4 à 7, 18, 19 et 20 de la Loi sur les lieux ines-thétiques dans les municipalités suivantes :

a) Kedgwick;b) le village de McAdam;c) Neguac;d) Saint-Louis-de-Kent; ete) le village de Saint-Hilaire.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

LE 15 DÉCEMBRE 20162016-316

En vertu de l’article 12 de la Loi sur les travaux publics, lelieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Trans-ports et de l’Infrastructure à céder à Donald A. Matheson, deSaint John (Nouveau-Brunswick), en contrepartie de 10 000 $,le bien désigné à l’annexe « A » ci-jointe, connu comme l’an-cien bien de Frances Mullin, situé au 615, rue Ready, àSaint John, au Nouveau-Brunswick.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

Integrated DNA Technologies Canada, Inc. Saint John 693221 2017 01 03

Wanita McGraw CPA C.P. Inc. Tracadie-Sheila 693259 2017 01 01

Hayden Holdings Inc. Fredericton 693282 2017 01 01

Team Equipment Rentals Inc. Saint John 693291 2017 01 01

MAINVILLE EXCAVATION ET CAGES INC. Caraquet 693381 2016 12 23

693383 NB INC. Saint John 693383 2016 12 26

693386 NB INC. Moncton 693386 2016 12 28

693393 N.B. Ltd. Sussex Corner 693393 2016 12 28

Penney eCommerce Inc. Burton 693400 2016 12 29

Adam Chamberlain Professional Corporation Fredericton 693403 2016 12 29

Michlin Investments Ltd. Saint John 693404 2016 12 29

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 4: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 94 Gazette royale — 25 janvier 2017

693407 NB Ltd. Miramichi 693407 2016 12 29

Dr. Amy Russell Professional Corporation Fredericton 693414 2017 01 01

693416 N.B. Inc. Upper Kingsclear 693416 2016 12 29

693421 NB LTD. Rothesay 693421 2016 12 29

Thriller Wellness Inc. Saint John 693425 2016 12 29

Moncton Professional Marketing & More Inc. Dieppe 693426 2016 12 29

V-FIVE IT SERVICES INC. Saint John 693427 2016 12 29

RALPH H. GREEN P.C. INC. Rothesay 693433 2016 12 29

BIG DOG INVESTMENTS INC. Moncton 693434 2016 12 29

Farevalley Power Sports Sales & Service Inc. Jacksonville 693435 2016 12 31

CRAIG MWM REPAIRS LTD. Windsor 693436 2016 12 29

Andrew W. Costin Professional Corporation Saint John 693437 2016 12 29

Philroy Services Inc. Kilburn 693439 2016 12 29

693442 N.B. Inc. Fredericton 693442 2017 01 01

693443 N.B. Inc. Fredericton 693443 2016 12 29

Banks Bros Realty Inc. Fredericton 693444 2017 01 01

Fundy Tax Prep & Accounting Services Ltd. St George 693450 2016 12 30

Taj Indian Cuisine Inc. Moncton 693465 2017 01 01

EWH1 Consulting Inc. Rothesay 693467 2016 12 30

693468 N.B. Inc. Moncton 693468 2016 12 30

Gary Inman Trucking Ltd. Kilburn 693470 2016 12 30

693478 New Brunswick Inc./693478 Nouveau-Brunswick Inc. Saint John 693478 2017 01 01

Hearts Ease Homes Ltd. Saint John 693482 2017 01 02

GRONDIN DUBÉ REALTY INC. Dieppe 693486 2017 01 03

Herbstemple Spices Ltd. Fredericton 693495 2017 01 03

Silmat Transportation Inc. Moncton 693496 2017 01 03

Morgan Mean’s Contracting Ltd. Hartland 693500 2017 01 03

YVANO SPECIALTY MEATS NB INC. Grand-Sault / Grand Falls 693505 2017 01 03

THOMAS MANN CONSULTING LTD. Fredericton 693506 2017 01 03

LGN Services Inc. Moncton 693511 2017 01 04

Hopewell Developments Inc. Hopewell Cape 693518 2017 01 04

The TE Coughy Shop Inc. Fredericton 693519 2017 01 04

KATMAC ENTERPRISES LTD. Quispamsis 693522 2017 01 04

693523 NB LTD. Moncton 693523 2017 01 04

Page 5: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 95 Gazette royale — 25 janvier 2017

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on January 4, 2017 under the name of “GESTION MARILOU THÉRIAULT LTÉE”, beingcorporation #693531, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation, correcting thename of the corporation from “GESTION MARILOU THÉRIAULT LTÉE” to “GESTION MARYLOU THÉRIAULT LTÉE”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 4 janvier 2017 à « GESTION MARILOU THÉRIAULT LTÉE »,dont le numéro de corporation est 693531, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisantpasser le nom de la corporation de « GESTION MARILOU THÉRIAULT LTÉE » à « GESTION MARYLOU THÉRIAULT LTÉE ».

_____________________________________________________

Juicy Couture Canada Inc. Saint John Canada 693229 2016 12 31

692860 NB Inc. Saint John Québec / Quebec 693288 2016 12 31

Modern Media Inc. Moncton Nouvelle-Écosse / 693356 2016 12 23Nova Scotia

ACL Bus Limited Saint John Nouvelle-Écosse / 693362 2016 12 22Nova Scotia

R. Chisholm Food Services Fredericton Ontario 693369 2016 12 23

Hanscome Farms Ltd. Perth-Andover Canada 693429 2016 12 29

_____________________________________________________

CVR HOME IMPROVEMENTS INC. 038181 2016 12 30

RAYDOR (1988) LIMITED 040945 2016 12 28

Dr. Gilles Verret Corporation Professionnelle 045228 2016 12 29

DALY’S HOME CARE INC. 058801 2016 12 30

SMITH SPECIAL CARE HOME LTD. 502204 2016 12 30

RESIDENCE COLLETTE RESIDENCE INC. 506228 2016 12 30

GREG SHADDICK TRUCKING LTD. 508699 2016 12 29

Quality Excavating Inc. 511097 2016 12 30

ROUSSEL MOTORS LTD. 512452 2016 12 29

515129 NB Inc. 515129 2016 12 29

Armour Holdings Inc. 515313 2016 12 28

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :

Previous ReferenceJurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 6: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 96 Gazette royale — 25 janvier 2017

DR FRANCOIS LEBLANC, P.C. INC. 601431 2016 12 30

Remka Enterprises Inc. 611025 2016 12 30

048698 N.B. Ltd. 611794 2016 12 28

Global Intermediate Finance Trust Corporation 615655 2016 12 23

C. Paul W. Smith Professional Corporation 615965 2016 12 29

C.P.W. Smith P.C. Inc. 615966 2016 12 29

624063 N.B. Inc. 624063 2016 12 30

Colbr Consulting Incorporated 627980 2016 12 29

Access Home Care Inc. 635134 2016 12 30

DR. KEVIN LEBLANC C.P. INC. 638096 2016 12 29

ROBALY HOMES INC. 638863 2016 12 30

J. Paul M. Harquail Professional Corporation 640585 2016 12 29

J. P. M. Harquail P. C. Inc. 640597 2016 12 29

Extreme Kitchens Inc. 643084 2016 12 30

D. FAMILY INVESTMENTS LTD. 648881 2016 12 29

BIG DOG ENTERPRISES INC. 653903 2016 12 30

K.H. Kyle Professional Corporation 654149 2016 12 29

MCF Roussel Ltd. 659532 2016 12 29

BURST WINDSHIELD REPAIR LTD. 660096 2016 12 28

Manning Investments Inc. 660817 2016 12 29

Stephen J. Hutchison Professional Corporation 661293 2016 12 29

Sugarloaf Estates Inc. 661924 2016 12 30

Ryan Oak Estates Inc. 661927 2016 12 30

Rebecca McGinn MD Professional Corporation 665294 2016 12 29

Stephen J. Hill Professional Corporation 667429 2016 12 29

Treecologic Inc. 669734 2017 01 04

Diamond Complex Estates Inc. 671230 2016 12 30

678275 NB INC. 678275 2016 12 29

HFT Holdings Ltd. 682960 2016 12 28

Daniel L. Stevenson PC Inc. 684164 2016 12 29

HARVEY FARM & FOREST LTD. 686635 2016 12 29

THANKFUL TOO SEAFOOD INC. 686760 2016 12 31

Bargus Holdings Ltd. 689456 2016 12 29

692031 N.B. Inc. 692031 2016 12 31

692785 NB INC. 692785 2017 01 02

LE ROITELET LTÉE 693378 2017 01 01

_____________________________________________________

Page 7: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 97 Gazette royale — 25 janvier 2017

505610 NB LTD. CYR GARAGE DOORS LTD. 505610 2017 01 03

ALORICA CUSTOMER CARE LTD./SERVICE À LA CLIENTELE ALORICA LTÉE

EGS CUSTOMER CARE LTD./SERVICE À LA CLIENTELE EGS LTÉE

508265 2017 01 01

615408 NB Inc. Wanita McGraw C.P. Inc. 615408 2017 01 01

J. E. Saunders Holdings Inc. J. E. SAUNDERS P.C. INC. 641672 2016 12 29

642389 NB Inc. André Paulin Corporation Professionnelle Inc. 642389 2017 01 01

ACSP MANAGEMENT INC. AC Stevenson & Partners PC Inc. 653428 2016 12 31

KHK Holdings Inc. K.H. Kyle PC Inc. 654148 2016 12 29

BTI RE Holdings Limited 666547 NB Ltd. 666547 2016 12 29

SJH Holdings Inc. S.J. Hill P.C. Inc. 667430 2016 12 29

OHI Holdings Inc. 669442 N.B. Limited 669442 2016 12 29

MJSN Investments Inc. M.R. Poirier Services P.C. Incorporated 674149 2016 12 29

OC Opportunities Limited 679905 N.B. Limited 679905 2016 12 29

LIBER Publishing Inc. M & M Legal Documents Inc. 690389 2016 12 30

A.T.R. Construction Ltd. ALCON CONSTRUCTION INC. 693124 2016 12 23

Wilson Insurance Ltd. 505588 N.B. LTD. 693290 2017 01 02

Butland’s Lobster Inc. 692605 N.B. Inc. 693293 2017 01 02

GRIZZLY BEAR HOLDINGS INC. VALLEY EQUIPMENT LIMITED 693379 2017 01 01

Maple A.L. Inc. 693319 NB INC. 693419 2017 01 01

Daniel L. Stevenson Professional Corporation Daniel L. Stevenson PC Inc. 693428 2017 01 01

_____________________________________________________

EAST COAST SHEET METAL LTD. EAST COAST SHEET METAL LTD.MODERN PLASTICS LTD.

Memramcook 692475 2017 01 01

GEORGE’S PLUMBING & HEATING(1985) LTD.

634982 NB Inc.George’s Plumbing & Heating (1985) Ltd. 688815 NB INC.

Dieppe 692938 2017 01 01

Cliff Jones Electrical 2000 Inc. CLIFF JONES ELECTRICAL 2000 INC.613013 NB Inc.

Dieppe 692942 2016 12 31

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

Page 8: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 98 Gazette royale — 25 janvier 2017

Kate Spade Canada Inc. Kate Spade Canada Inc.Juicy Couture Canada Inc.

Saint John 693230 2017 01 01

Huestis Insurance & Associates Ltd. EARL B. GLENN LTD.KDB HOLDINGS INC.Capital Insurance Services Ltd.Huestis Insurance & Associates Ltd.

Saint John 693242 2017 01 01

038491 N.B. LTD. 038491 N.B. Ltd.RICHARDSON BAUGHAN INVESTMENTS LIMITED

Sackville 693262 2016 12 31

LOUBANI FAMILY HOLDINGS INC. DR. M.M. LOUBANI PROFESSIONAL CORPORATIONLOUBANI FAMILY HOLDINGS INC.

Beresford 693271 2017 01 01

Coast Tire & Auto Service Ltd. Coast Tire (Summerside) Ltd.Coast Tire & Auto Service Ltd.

Saint John 693272 2017 01 01

649676 NB Inc. 649676 NB INC.691706 NB INC.

Shippagan 693280 2017 01 01

Oldcastle Building ProductsCanada, Inc. Les Materiaux deConstruction Oldcastle Canada, Inc.

Oldcastle Building Products Canada, Inc. Les Materiaux de Construction Oldcastle Canada, Inc.692860 NB Inc.

Saint John 693289 2017 01 01

505588 N.B. LTD. 505588 N.B. LTDWILSON INSURANCE LTD.

Fredericton 693290 2017 01 01

692605 N.B. Inc. BUTLAND’S LOBSTER INC.692605 N.B. INC.

Alma 693293 2017 01 02

Andritz Hydro Canada Inc. ANDRITZ HYDRO AFI, INC.Andritz Hydro Canada Inc. ANDRITZ HYDRO INSTALLATIONS INC./ LES INSTALLATIONSANDRITZ HYDRO INC.

Saint John 693294 2017 01 01

Lounsbury Company Limited 616226 N.B. Ltd.Lounsbury Company Limited 689611 N.B. Inc.

Moncton 693332 2017 01 01

D.A. LeBlanc P.C. Incorporated D.A. LeBlanc Services P.C. Inc.D.A. LeBlanc P.C. Incorporated

Moncton 693340 2017 01 01

CBRE Limited CBRE LIMITEDCBRE CONSULTING INC.

Fredericton 693341 2017 01 01

A.M. McDonald P.C. Incorporated A.M. McDonald P.C. IncorporatedA.M. McDonald Services P.C. Incorporated

Fredericton 693342 2017 01 01

J.E.B. Dysart P.C. Inc. J.E. Britt Dysart Professional CorporationJ.E.B. Dysart P.C. Inc.

Fredericton 693344 2017 01 01

RCC HOLDING INC. RCC HOLDING INC.L.D.R. HOLDING INC.

Memramcook 693352 2017 01 01

GHOST ROAD AUTO LTD. GHOST ROAD AUTO & MARINE LTD.692847 N.B. Ltd.

Chamcook 693353 2016 12 23

WIOSS Montreal Corporation LER Automatisations CorporationLER Solutions Corporation

Fredericton 693358 2017 01 01

Kelly Cove Salmon Ltd. Dutch Ledge Salmon Site Ltd.Kelly Cove Salmon Ltd.

Blacks Harbour 693364 2017 01 01

Page 9: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 99 Gazette royale — 25 janvier 2017

Capgemini Solutions Canada Inc./ Capgemini Financial Services Canada Inc.Solutions Capgemini Canada Inc.

IGATE TECHNOLOGIES (CANADA) INC.

Saint John 693365 2017 01 01

G.S. McMackin P.C. Inc. Gerald S. McMackin Professional CorporationG.S. McMackin P.C. Inc.

Rothesay 693366 2017 01 01

Hugh J. Cameron Professional Corporation Hugh J. Cameron Professional CorporationH.J. Cameron P.C. Inc.

Fredericton 693368 2017 01 01

VC Renovations (2017) Inc. VC Renovations Inc.692169 N.B. INC.

Campbellton 693376 2017 01 01

LE ROITELET LTÉE MARTIN N. LIMITEELE ROITELET LTEE

Savoie Landing 693378 2017 01 01

VALLEY EQUIPMENT LIMITED BENCAL HOLDINGS LTD.GRIZZLY BEAR HOLDINGS LTD.Valley Equipment Limited

Hartland 693379 2017 01 01

Carl S. Hay Ltd. CARL S. HAY LTD.VALLEY BOWL-O-RAMA LIMITED

Fredericton 693380 2017 01 01

AKELIUS REAL ESTATEMANAGEMENT LTD.

AKELIUS REAL ESTATE MANAGEMENT LTD.AKELIUS FACILITY MANAGEMENT LTD.

Moncton 693385 2017 01 01

503763 NB INC. 503763 NB Inc.Valkyrie Holdings Inc.635621 N.-B. Inc.

Dieppe 693388 2017 01 01

Maxim Construction Inc. Maxim Construction Inc.693029 N.B. Inc.

Saint John 693389 2017 01 01

661682 N.B. INC. Ross Anderson Developments Ltd.661682 N.B. Inc.

Fredericton 693395 2017 01 01

Kensington AssociatesManagement Consulting Inc.

038852 N.B. LTD.629703 N.B. Inc.Broadway Developments Ltd.

Dieppe 693399 2017 01 01

Woodstock Duty Free Shop Inc. WOODSTOCK DUTY FREE SHOP INC.MARITIME EXCHANGE INC.

Belleville 693402 2017 01 01

Blair C. Fraser Professional Corporation B.C. Fraser P.C. Inc.Blair C. Fraser Professional Corporation

Moncton 693405 2017 01 01

Hélène L. Beaulieu Professional Corporation Helene L. Beaulieu Professional CorporationH.L. Beaulieu P.C. Inc.

Moncton 693406 2017 01 01

686765 NB Ltd. 665811 N.B. Ltd.686765 NB LTD.

Riverview 693409 2017 01 01

Jada Holdings Ltd. HANNAY’S LIMITEDBrent Hannay Holdings Ltd.Jada Holdings Ltd.

Moncton 693410 2017 01 01

ACS&P Management GP Inc. RIVERVIEW DATA SERVICES LTD.ACS&P Holdings Inc.ACS&P Management GP Inc.

Riverview 693411 2017 01 01

Integrated Meaning Systems Ltd. Integrated Meaning Systems Ltd.Intelligent Organizational Systems Inc.

Bayswater 693418 2017 01 01

Page 10: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 100 Gazette royale — 25 janvier 2017

693319 NB INC. MAPLE A.L INC.693319 NB INC.

Kedgwick River 693419 2017 01 01

TANN PAPER LIMITED TANN HOLDINGS INC.TANN PAPER LIMITED

Woodstock 693423 2017 01 01

ATLANTIC MEDICAL CORPORATION ATLANTIC MEDICAL CORPORATION 692824 NB INC.

Waterville 693424 2017 01 01

Daniel L. Stevenson PC Inc. Daniel L. Stevenson Professional CorporationDaniel L. Stevenson PC Inc.

Fredericton 693428 2017 01 01

Ralna Group Ltd. RALNA GROUP LTD.Hanscome Farms Ltd.

Perth-Andover 693430 2017 01 01

626877 N.B. Inc. 626877 N.B. Inc.662058 N.B. Inc.

Fredericton 693431 2017 01 01

Peter R. Forestell Professional Corporation Peter R. Forestell Professional CorporationPeter R. Forestell PC Inc.

Saint John 693455 2017 01 01

_____________________________________________________

ROBERT COGSWELL LIMITED Geary 003984 2016 12 22

D & D DRUGS LTD. Quispamsis 031371 2016 12 31

DYP HOLDINGS INC. Dieppe 036108 2016 12 21

VIVA CANADA INC. Saint John 051187 2016 12 23

AERO PENINSULE LTEE Tracadie-Sheila 052032 2016 12 31

ROYBYRNS & ASSOCIATES INC. Dieppe 506494 2016 12 31

SERVICES FINANCIERS G.A.P. FINANCIAL SERVICES INC. Dieppe 609081 2016 12 31

Tobacco Intertrade Limited Saint John 619197 2016 12 23

Plastiflex Canada Inc. Saint John 626627 2016 12 30

Almirall Limited Saint John 662918 2016 12 31

DL Information Services Canada Inc. Saint John 668739 2016 12 31

BYRNS HOLDINGS INC. Dieppe 673854 2016 12 31

CHRISTEPH HOLDINGS INC. Dieppe 673856 2016 12 31

MCC ELECTRIC INC. Quispamsis 692242 2016 12 31

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 11: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 101 Gazette royale — 25 janvier 2017

SHARP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 015058 2016 12 29

Toulouse Management Ltd. 515792 2016 12 22

_____________________________________________________

9351-7183 Québec inc. Québec / Quebec Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693359 2016 12 23

JOHN D. LANDRY INSURANCE AGENCY LTD.

Ontario Tristan HoveyFredericton

693384 2016 12 28

TRADER CORPORATION Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693397 2016 12 29

6785743 CANADA INC. Canada Triston HoveyFredericton

693449 2016 12 30

Risim Communications Inc. Canada Richard SimoensDieppe

693452 2016 12 30

PROFUNDS HOLDINGS INC. Ontario Timothy T. CulbertWoodstock

693502 2017 01 03

_____________________________________________________

Richardson Oilseed Products Limited Richardson Oilseed Eastern Canada Limited 659768 2017 01 01

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

Page 12: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 102 Gazette royale — 25 janvier 2017

Lenscrafters International, Inc. États-Unis / United States

Saint John 624872 2017 01 03 2017 04 02

ELMWORTH ENERGY CORPORATION

Alberta Saint John 633788 2016 10 31 2017 04 02

GAS DRIVE GLOBAL LTD. Canada Saint John 660029 2017 01 03 2017 04 02

R. Chisholm Food Services Inc. Ontario Fredericton 667011 2017 01 03 2017 04 02

ANDRITZ HYDRO INSTALLATIONSINC./LES INSTALLATIONSANDRITZ HYDRO INC.

Québec / Quebec Saint John 669160 2017 01 03 2017 04 02

Mandeville Wealth ServicesInc./Services de Gestion de Patrimoine Mandeville Inc.

Ontario Saint John 676354 2017 01 03 2017 04 02

_____________________________________________________

Club Tennis Chaleur Inc. Petit-Rocher 693354 2016 12 23

_____________________________________________________

ASSOCIATION DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS MEMBRES D’ÉQUIPAGE INC.

024948 2016 12 14

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, the Director has made a decision to cancel the registrationof the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,le Directeur a décidé d’annuler l’enregistrement des corporations ex-traprovinciales suivantes :

Proposed CancellationReference Notice Date Date / Date deNumber Date de l’avis l’annulation projetée

Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour année mois jour

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires ont été émises à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 13: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 103 Gazette royale — 25 janvier 2017

PLACE HISTORIQUE DU MADAWASKA INC 024162 2016 12 21

Friends of Cameroon Inc. 668270 2016 12 22

Butterflies and BumblebeesDaycare

Ashley King Saint John 692927 2017 01 01

JBC Mechanical Services Jeremy Bryant Cromwell The Glades 693070 2016 12 08

DK Open Concepts Danny C Kenny Riverview 693174 2016 12 14

AGFiQ HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT INC.

Fredericton 693265 2017 01 01

AGFiQ Asset Management HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT INC.

Fredericton 693266 2017 01 01

Madd Hatter Ink Ronald Pellerin Miramichi 693309 2017 01 01

NATIONAL Public Relations 9351-7183 Québec inc. Saint John 693360 2016 12 23

La Cabinet de relationsPubliques NATIONAL

9351-7183 Québec inc. Saint John 693361 2016 12 23

VC Renovations VC Renovations (2017) Inc. Campbellton 693377 2017 01 01

MR. TASK LABOUR ANDRENOVATIONS

RHEAL LEBLANC Saint John 693417 2016 12 29

Murchies Micro Brew Matt Murchison Oakland 693420 2016 12 29

JM ONLINE MARKETING VENTURES

Jeremy Misener Sackville 693422 2016 12 29

Menage Cleanet Mcgraw Edit McGraw Tracadie-Sheila 693438 2016 12 29

M&S Basics Renovations R Matthew Sherwood Maugerville 693440 2016 12 29

WINK Beauty Bar & Lash Lounge Beth Purcell Moncton 693441 2016 12 29

UTOPIA FEET CLINIC Courtney Babineau Utopia 693445 2016 12 29

Atlantic Land Development Caleb Morton Moncton 693446 2016 12 30

Pigeon Writing and Editing Kate Wallace Rothesay 693447 2016 12 30

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,the surrender of charter has been accepted and the company has beendissolved:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, l’abandon dela charte des corporations suivantes a été accepté, et que celles-ci sontdissoutes :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de réference année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 14: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 104 Gazette royale — 25 janvier 2017

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMPartnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

In relation to the certificate of business name registered on December 15, 2016, under the Act, under the name of “KAY’S CUSTOM FRAMING”,being file #693202, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the address be corrected to read “500 HillsboroughRoad, Riverview, NB E1B 4E7”.

Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 15 décembre 2016 en vertu de la Loi sous le nom de « KAY’SCUSTOM FRAMING », dont le numéro d’appellation commerciale est 693202, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, quel’adresse soir corrigé pour qu’elle se lise comme suit : « 500 Hillsborough Road, Riverview, NB E1B 4E7 ».

_____________________________________________________

LG McKay Cad Drafting Service Lawrence McKay Quispamsis 693461 2016 12 30

BareHeart Natural Therapies Kate Armstrong Belleisle Creek 693466 2016 12 30

Windu Pottery Lee Caswell Fredericton 693469 2016 12 30

G MCKILLOP CUSTOMS George McKillop Haneytown 693471 2016 12 30

Aj’s Air plant and oddities Alan McCann Eel River Crossing 693472 2016 12 30

Crowley Productions Sean Crowley Morrisdale 693473 2016 12 30

IFR Mobile Repair Ian Ross Fredericton 693474 2016 12 30

C & P Equipment Solutions Cameron Pawulski Waasis 693475 2016 12 30

5F Design Group Shelley Fyffe Kingston 693476 2017 01 01

Tremblett Photography Melissa Susan Caroline Tremblett Sussex Corner 693477 2017 01 01

East Imaging By Alisha Kelly Alisha Kelly Riverview 693479 2017 01 01

John Sampson Renovations John Sampson Fredericton 693480 2017 01 02

Mario Durette Consulting Mario Durette Fredericton 693481 2017 01 02

Simon Banville Consulting Simon Banville Burton 693497 2017 01 03

Malcolm Angus Consulting Malcolm Angus Burton 693498 2017 01 03

Virivus Consulting Wayne Evans Burton 693509 2017 01 04

Bellwether Consignment Laurel Green Fredericton 693510 2017 01 04

Personally Made Designs Katie Tibbetts Saint John 693512 2017 01 04

Cabinet Juridique MonicaPlourde Law Office

Monica Plourde Edmundston 693515 2017 01 04

Rj Bertin Consulting Ronald Bertin Fredericton 693516 2017 01 04

Oasis Farmery Andrew Mathis Durham Bridge 693517 2017 01 04

Wanigan Consulting Christy Arseneau Dalhousie 693521 2017 01 04

HARRIS REBAR Harris Steel ULC Saint John 316673 2016 12 30

NU SKIN NU SKIN INTERNATIONAL, INC.

Saint John 341355 2016 12 29

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 15: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 105 Gazette royale — 25 janvier 2017

Victoria Mills Inn Susan T Wilson Wheaton Settlement 346569 2016 12 28

PATTISON SIGN GROUP JIM PATTISONINDUSTRIES LTD.

Saint John 353441 2016 12 29

Peppers’ House Antiques Owen Fowler Lower Saint Marys 621817 2017 01 02

J. M. Witzke Rod Maker John Witzke Flatlands 622724 2017 01 04

CIT Rail Resources CIT Financial (Alberta)ULC Services Financiers CIT (Alberta) ULC

Saint John 627135 2016 12 28

Shuning Xie Clinic Shuning Xie Fredericton 628297 2017 01 01

SHAW TRACKING Shaw Satellite Services Inc. / Fredericton 628858 2016 12 29Services Satellites Shaw Inc.

STATION WOODWORKING Mark Nickerson Rusagonis 629317 2016 12 30

Ledgers (Saint John) Robert Taylor Saint John 629583 2017 01 04

DIRECT ENERGY BUSINESS SERVICES

DIRECT ENERGY BUSINESSSERVICES LIMITED

Saint John 630252 2016 12 29

Raine Drops Day Spa Melissa Carson Keswick 658222 2016 12 23

Elaine Howell Family and Custody Elaine Howell Fredericton 659899 2016 12 29Consulting

ECCO Environmental Consulting &Contracting

Pario Engineering &Environmental Sciences LP

Fredericton 660508 2016 12 23

Bonaventure Software Doreen Clemons Grande-Digue 661366 2017 01 01

Sprott Asset Management Sprott Asset Management LP Saint John 661421 2016 12 29

Les Éditions des Merisiers Richard Plourde Edmundston 661704 2016 12 31

Celestial Treasures Paula Hunter St George 661803 2017 01 01

Binary Ocean Software Dennis Freeberg Grande-Digue 662303 2017 01 01

_____________________________________________________

SPENCER ENVIRONMENTAL Stanley 347951 2017 01 01

Domac Building Supplies Riverview 653255 2016 12 29

Final Cut Machining Richmond Corner 653479 2016 12 31

Fundy Tax Prep and Accounting Services St George 660537 2016 12 29

Besthome Hardware & Building Supplies Florenceville 668612 2016 12 29

HOME ALONE PET CARE Fredericton 686074 2016 12 31

Farevalley Power Sports Sales & Service Jacksonville 688681 2016 12 31

LGN Services Moncton 690028 2017 01 04

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 16: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 106 Gazette royale — 25 janvier 2017

Barreau du Nouveau-BrunswickVU la Loi de 1996 sur le Barreau

etDANS L’AFFAIRE de la radiation de

LISA MCDONALDAVIS DE RADIATION

Le 15 novembre 2016, un sous-comité de discipline du Barreaua ordonné que Lisa McDonald de Moncton (N.-B.) soit radiéedu Barreau à compter du 15 novembre 2016, conformément àl’alinéa 60(1)d) de la Loi de 1996 sur le Barreau. Le Comité dediscipline a statué que Lisa McDonald avait mal géré les fondsdu client, ce qui comprend le détournement des fonds en fiduciedu client. Lisa McDonald a fourni un service de mauvaise qua-lité aux clients, ce qui comprend avoir induit les clients en er-reur, avoir omis de rendre les services juridiques qu’elle s’étaitengagée à rendre, avoir omis de renseigner les clients, avoirmanqué à son obligation du secret professionnel envers unclient, avoir omis de respecter ses obligations en vertu de la Loiet avoir négligé de tenir un compte en fiducie conformémentaux Règles uniformes sur les comptes en fiducie; ces manque-ments constituent une violation des Chapitre 1 (L’intégrité),2 (La compétence), 3 (La qualité des services), 4 (La consulta-tion), 5 (Le secret professionnel), 7 (Conservation des biens duclient), 9 (Les honoraires), 10 (Le désistement) et 23 (Évitertoute conduite douteuse) du Code de déontologie profession-nelle du Barreau du Nouveau Brunswick ainsi que des Règles 3et 4 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie et de laRègle 79(2) des Règles générales prises sous le régime de la Loide 1996 sur le Barreau.

Shirley C. MacLean, c.r., Registraire des plaintes

________________

Barreau du Nouveau-BrunswickDANS L’AFFAIRE de la Loi de 1996 sur le Barreau

etDANS L’AFFAIRE de la suspension de

YASSIN CHOUKRI, c.r.AVIS DE SUSPENSION

SACHEZ que le Comité des plaintes du Barreau, lors d’une réu-nion tenue le 11 octobre 2016, a ordonné la suspension tempo-raire de Yassin Choukri, c.r., de Fredericton (Nouveau-Brunswick), un membre du Barreau, conformément àl’alinéa 53(1)(a) de la Loi de 1996 sur le Barreau. Cette suspen-sion restera en vigueur jusqu’à ce que le Comité de disciplinedu Barreau ait statué définitivement sur des plaintes portéescontre Yassin Choukri, c.r.

Shirley C. MacLean, c.r., Registraire des plaintes

Avis

Law Society Of New BrunswickIN THE MATTER of the Law Society Act, 1996

andIN THE MATTER of the disbarment of

LISA McDONALDNOTICE OF DISBARMENT

On November 15, 2016, a panel of the Discipline Committee ofthe Law Society ordered that Lisa McDonald of Moncton, N.B.,be disbarred from the Law Society pursuant to paragraph60(1)(d) of the Law Society Act, 1996 effective November 15,2016. The Discipline Committee found that Lisa McDonaldmishandled client funds, including misappropriation of clienttrust funds. Lisa McDonald provided a poor quality of serviceto clients, including misleading clients, neglecting to performlegal services she had undertaken to complete, failing to providereports to clients, breached her duty of confidentiality to a cli-ent, failed to respect legislated obligations and failing to main-tain a trust account in compliance with the Uniform Trust Ac-count Rules all of which constitute violations of Chapters 1(Integrity), 2 (Competence), 3 (Quality of Service), 4 (AdvisingClients), 5 (Confidentiality), 7 (Preservation of Client’s Prop-erty), 9 (Fees), 10 (Withdrawal), and 23 (Avoiding Question-able Conduct) of the Law Society of New Brunswick Code ofProfessional Conduct, Rules 3 and 4 of the Uniform Trust Ac-count Rules and Rule 79(2) of the General Rules under the LawSociety Act, 1996.

Shirley C. MacLean, Q.C., Registrar of Complaints

________________

Law Society of New BrunswickIN THE MATTER of the Law Society Act, 1996

andIN THE MATTER of the suspension of

YASSIN CHOUKRI, Q.C.NOTICE OF SUSPENSION

PLEASE NOTE that the Complaints Committee of the Law So-ciety, at a meeting held on October 11, 2016, ordered, pursuantto paragraph 53(1)(a) of the Law Society Act, 1996, that YassinChoukri, Q.C., of Fredericton, New Brunswick, a member ofthe Law Society, be suspended on an interim basis from thepractice of law, pending final disposition by the DisciplineCommittee of complaints filed against Yassin Choukri, Q.C.

Shirley C. MacLean, Q.C., Registrar of Complaints

Notices

Page 17: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 107 Gazette royale — 25 janvier 2017

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, paragr. 1(2)

Destinataires : Joseph Robert Lavoie et Marie Jocelyne Lavoie,débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éven-tuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,ch. P-19. Biens en tenure libre situés au 307, chemin Portage, àGrand-Sault, comté de Victoria, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est 65004855, et correspondant aumême lot ayant été transféré à Joseph Robert Lavoie etMarie Jocelyne Lavoie par l’acte de transfert enregistré dans lesystème d’enregistrement foncier le 20 avril 2005, sous le nu-méro 20136777.Avis de vente donné par la Banque Bridgewater, créancière hy-pothécaire. La vente aura lieu le jeudi 9 février 2017, à 11 h,heure locale, à l’hôtel de ville de Grand-Sault, 131, rue Plea-sant, Grand-Sault (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce pu-bliée dans les éditions des 11, 18, 20 et 25 janvier 2017 et du1er février 2017 du Victoria Star.

Romain Viel, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque Bridgewater, Barker House, 570, rue Queen, bu-reau 600, C.P. 610, succursale A, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-453-0920; télécopieur :506-458-9903.

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, paragr. 1(2)

Destinataires : Eric David Hoye et Heidi Lynn Hoye, débiteurshypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B 1973,ch. P 19. Biens en tenure libre situés au 2779, route 510, à Tar-gettville, au Nouveau-Brunswick, et correspondant au même lotayant été transféré à Eric David Hoye et Heidi Lynn Hoye parl’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement le26 juin 2009, sous le numéro 27343152.Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. Lavente aura lieu le 9 février 2017, à 11 h, heure locale, à l’hôtelde ville de Bouctouche, 30, rue Évangéline, Bouctouche (Nou-veau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des12, 19 et 26 janvier, et du 2 février 2017 du Times & Transcript.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Sociétéhypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Avis de vente

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Joseph Robert Lavoie and Marie Jocelyne Lavoie, originalmortgagors and all others whom it may concern. Sale pursuantto the terms of the mortgage and the Property Act, RSNB 1973,c.P-19, as amended. Freehold property situated at 307 PortageRoad, Town of Grand Falls, in the County of Victoria and Prov-ince of New Brunswick, and being identified as PID 65004855,the same lot conveyed to Joseph Robert Lavoie and Marie Joc-elyne Lavoie by Deed registered in the Land Titles System onApril 20, 2005, as Number 20136777.

Notice of Sale given by Bridgewater Bank, mortgagee. Sale tobe held at Grand Falls Municipal Town Hall, 131 PleasantStreet, Grand Falls, New Brunswick on Thursday, February 9,2017, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement ofthe Notice of Mortgage Sale in the Victoria Star dated January11, 18, 25 and February 1, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for Bridgewater Bank, Per: RomainViel, Suite 600, Barker House, 570 Queen Street, PO Box 610,Station A, Fredericton, New Brunswick E3B 5A6 Telephone:506-453-0920, Facsimile: 506-458-9903.

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Eric David Hoye and Heidi Lynn Hoye, original Mortgag-ors, and all others whom it may concern. Sale pursuant to termsof the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19and Acts in amendment thereof. Freehold property being situ-ated at 2779 Route 510, Targettville, New Brunswick, the samelot conveyed to Eric David Hoye and Heidi Lynn Hoye by Deedregistered in the Land Titles Office on June 26, 2009, as number27343152.

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale tobe held at Bouctouche Municipal Town Hall, located at 30Evangeline Street, Bouctouche, New Brunswick, on the 9th dayof February, 2017, at the hour of 11:00 a.m., local time. See ad-vertisement of Notice of Sale in the Times and Transcript datedJanuary 12, 19, 26 and February 2, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, SuiteS400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6,Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095.

________________

Notices of Sale

Page 18: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 108 Gazette royale — 25 janvier 2017

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, paragr. 1(2)

Destinataires : Jodi Lynn Borenstein, débitrice hypothécaireoriginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée envertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de laLoi sur les biens, L.R.N.-B 1973, ch. P-19. Biens en tenure libresitués au 102-50, promenade Downsview, à Saint John, auNouveau-Brunswick, et correspondant au même lot ayant ététransféré à Jodi Lynn Borenstein par l’acte de transfert enregis-tré au bureau de l’enregistrement foncier le 25 novembre 2011,sous le numéro 30884267.Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. Lavente aura lieu le 8 février 2017, à 11 h, heure locale, au palaisde justice de Saint John, 10, place Peel, Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 12, 19et 26 janvier et du 2 février 2017 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Sociétéhypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, paragr. 1(2)

Destinataires : Jodi Lynn Borenstein, débitrice hypothécaireoriginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée envertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de laLoi sur les biens, L.R.N.-B 1973, ch. P-19. Biens en tenure libresitués au 106-50, promenade Downsview, à Saint John, auNouveau-Brunswick, et correspondant au même lot ayant ététransféré à Jodi Lynn Borenstein par l’acte de transfert enregis-tré au bureau de l’enregistrement foncier le 25 novembre 2011,sous le numéro 30884291.Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. Lavente aura lieu le 8 février 2017, à 11 h 15, heure locale, au pa-lais de justice de Saint John, 10, place Peel, Saint John (Nou-veau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des12, 19 et 26 janvier et du 2 février 2017 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Sociétéhypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Destinataire : Guy Losier, 120, rue McLean, Sussex, comté deKings et province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothé-caire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Biens en tenure libre situé au 120, rue McLean, à Sussex, dansle comté de Kings et province du Nouveau-Brunswick et dontle NID est 00055525.

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c. S-2, s. 1(2)

To: Jodi Lynn Borenstein, original Mortgagor, and all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 102-50Downsview Drive, Saint John, New Brunswick, the same lotconveyed to Jodi Lynn Borenstein by Transfer registered in theLand Titles Office on November 25, 2011, as document number30884267.

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale tobe held at Saint John Court House, located at 10 Peel Plaza,Saint John, New Brunswick, on the 8th day of February, 2017,at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of No-tice of Sale in the Telegraph-Journal dated January 12, 19, 26and February 2, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, SuiteS400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6,Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095.

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Jodi Lynn Borenstein, original Mortgagor, and all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 106-50Downsview Drive, Saint John, New Brunswick, the same lotconveyed to Jodi Lynn Borenstein by Transfer registered in theLand Titles Office on November 25, 2011, as document number30884291.

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale tobe held at Saint John Court House, located at 10 Peel Plaza,Saint John, New Brunswick, on the 8th day of February, 2017,at the hour of 11:15 a.m., local time. See advertisement of No-tice of Sale in the Telegraph-Journal dated January 12, 19, 26and February 2, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, SuiteS400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6,Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095.

________________

TO: GUY LOSIER, 120 McLean Street, Sussex, KingsCounty and Province of New Brunswick, mortgagor;

AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises known as PID 00055525, situate, lying andbeing at 120 McLean Street, in Sussex, Kings County and Prov-ince of New Brunswick.

Page 19: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 109 Gazette royale — 25 janvier 2017

NOTICE OF SALE given by Caisse populaire acadienne ltée(formerly Fédération des Caisses Populaires AcadiennesLimitée) as Mortgagee and Holder of the First Mortgage. Saleby virtue of the power of sale contained in the mortgage and theProperty Act.Sale to be held on the 7th day of February, 2017, at 1:30 p.m., atSussex Town Hall, located at 524 Main Street, in Sussex, inKings County, New Brunwick.SEE ADVERTISEMENT IN KINGS COUNTY RECORD.

JONATHAN ROCH NOËL, Solicitor for Caisse populaire aca-dienne ltée

________________

To: MARC JOSEPH HEBERT and YVETTE MARIEHEBERT, Mortgagor, AND TO ALL OTHERS WHOM ITMAY CONCERN Freehold property situate at 147 Carleton STREET, Rogers-ville, in the County of Northumberland and Province ofNew Brunswick, having PID number 40395873. Notice of Salegiven by the CAISSE POPULAIRE ACADIENNE LTÉE,holder of the first mortgage. The sale will be held on February9, 2017, at 2:00 p.m., at the entrance of the Service New Bruns-wick building, 9239 Main Street, Richibucto, New Brunswick.See advertisement in L’ACADIE NOUVELLE.

Yves Robichaud, Solicitor for the Mortgagor, CAISSEPOPULAIRE ACADIENNE LTÉE

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Thomas Percy Starkey and Susan Geraldine Eades, originalMortgagors, and all others whom it may concern. Sale pursuantto terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973,c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property beingsituated at 434 Woolastook Drive, Grand Bay-Westfield, NewBrunswick, the same lot conveyed to Thomas Percy Starkey andSusan Geraldine Eades by Transfer registered in the Land TitlesSystem on November 1, 2004, as document number 19387829.

Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia as Mortgagee.Sale to be held at the Saint John Provincial Building located at10 Peel Plaza, Saint John, New Brunswick on the 9th day ofFebruary, 2017, at the hour of 11:00 a.m., local time. See adver-tisement of Notice of Sale in the Telegraph-Journal dated Jan-uary 12, 19, 26 and February 2, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele-phone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095.

________________

AVIS DE VENTE donné par Caisse populaire acadienne ltée(anciennement Fédération des Caisses Populaires Aca-diennes Limitée), titulaire de la première hypothèque en vertudu pouvoir de vente contenu dans l’acte d’hypothèque et de laLoi sur les biens.La vente aura lieu le 7 février 2017, à 13 h 30 à l’entrée de l’Édi-fice municipal de Sussex au 524, rue Principale, à Sussex, dansle comté de Kings, au Nouveau-Brunswick.VOIR L’ANNONCE DANS “KINGS COUNTY RECORD”.

JONATHAN ROCH NOËL, Avocat pour la Caisse populaireacadienne ltée

________________

Destinataires: MARC JOSEPH HEBERT et YVETTEMARIE HEBERT, *débiteur hypothécaire+, ET À TOUTAUTRE INTÉRESSÉ EVENTUELLieux en tenure libre situés à 147 RUE Carleton, Rogersville,comté de Northumberland et province du Nouveau-Brunswick, ayant comme numéro d’identification 40395873.Avis de vente donné par la CAISSE POPULAIREACADIENNE LTÉE, titulaire de la première hypothèque. Lavente aura lieu le 9 février 2017, à 14 h, à l’entrée de l’édificede Service Nouveau-Brunswick, 9239, rue Main, Richibucto,Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans L’ACADIENOUVELLE.

Yves J. Robichaud, avocat de la créancière hypothécaire,CAISSE POPULAIRE ACADIENNE LTÉE

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, paragr. 1(2)

Destinataires : Thomas Percy Starkey et Susan Geraldine Eades,débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éven-tuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B 1973,ch. P-19. Biens en tenure libre situés au 434, promenadeWoolastook, à Grand Bay-Westfield, au Nouveau-Brunswick,et correspondant au même lot ayant été transféré à ThomasPercy Starkey et Susan Geraldine Eades par l’acte de transfertenregistré dans le système d’enregistrement foncier le 1er no-vembre 2004, sous le numéro 19387829.Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 9 février 2017, à 11 h,heure locale, à l’édifice provincial de Saint John, 10, place Peel,Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dansles éditions des 12, 19 et 26 janvier et du 2 février 2017 duTelegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main,bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Page 20: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 110 Gazette royale — 25 janvier 2017

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To Catherine Elizabeth Godin, original Mortgagor, and to allothers whom it may concern. Sale pursuant to terms of theMortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Actsin amendment thereof. Freehold property being situated at 3311Route 490, Dundas, New Brunswick, the same lot conveyed toCatherine Elizabeth Godin by Transfer registered in the LandTitles System on November 6, 2007, as Number 24764996.

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mort-gagee. Sale to be held at Moncton City Hall located at 655 MainStreet, Moncton, New Brunswick on the 13th day of February,2017, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement ofNotice of Sale in the Times & Transcript dated January 16, 23,30 and February 6, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, SuiteS400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6,Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095.

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To Tammy Rosine Duffy, original Mortgagor, and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 589 AndersonStreet, Miramichi, New Brunswick, the same lot conveyed toTammy Rosine Duffy by Transfer registered in the Land TitlesSystem on August 6, 2004, as document number 18874785.

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mort-gagee. Sale to be held at or near the front of the Court House forthe Judicial District of Miramichi, 673 King George Highway,Miramichi, New Brunswick on the 10th day of February, 2017,at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of No-tice of Sale in The Miramichi Leader dated January 13, 20, 27and February 3, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, SuiteS400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6,Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095.

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, paragr. 1(2)

Destinataires : Catherine Elizabeth Godin, débitrice hypothé-caire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuéeen vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles dela Loi sur les biens, L.R.N.-B 1973, ch. P-19. Biens en tenurelibre situés au 3311, Route 490, à Dundas, au Nouveau-Brunswick, et correspondant au même lot ayant été transféré àCatherine Elizabeth Godin par l’acte de transfert enregistrédans le système d’enregistrement foncier le 6 novembre 2007,sous le numéro 24764996.Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 13 février 2017, à 11 h,heure locale, à l’hôtel de ville de Moncton, 655, rue Main,Moncton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dansles éditions des 16, 23 et 30 janvier et du 6 février 2017 duTimes & Transcript.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Sociétéhypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, paragr. 1(2)

Destinataires : Tammy Rosine Duffy, débitrice hypothécaireoriginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée envertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de laLoi sur les biens, L.R.N.-B 1973, ch. P-19. Biens en tenure libresitués au 589, rue Anderson, à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, et correspondant au même lot ayant été transféré àTammy Rosine Duffy par l’acte de transfert enregistré dans lesystème d’enregistrement foncier le 6 août 2004, sous le nu-méro 18874785.Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 10 février 2017, à 11 h,heure locale, sur les lieux ou près du palais de justice de la cir-conscription judiciaire de Miramichi, 673, route King George,Miramichi (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dansles éditions des 13, 20 et 27 janvier et du 3 février 2017 duMiramichi Leader.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Sociétéhypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

Page 21: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 111 Gazette royale — 25 janvier 2017

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette coordinator, Legislative Services,no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’spublication. Each document must be separate from the cover-ing letter. Signatures on documents must be immediately fol-lowed by the printed name. The Royal Gazette coordinatormay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of CourtNote: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

Notice to Advertisers

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir au coordonnateur de la Gazetteroyale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept joursavant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparéde la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivreimmédiatement la signature. Le coordonnateur de la Gazetteroyale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi-sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-ministratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (àl’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédureNota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po

sur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

Avis aux annonceurs

Page 22: The Royal Gazette / Gazette Royale (17/01/25) · The Royal Gazette — January 25, 2017 92 Gazette royale — 25 janvier 2017 Board, representing Region Five, for a term of three

The Royal Gazette — January 25, 2017 112 Gazette royale — 25 janvier 2017

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney_general/royal_gazette.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plusshipping and handling where applicable.

Notice: The telephone number for The Royal Gazette haschanged. Please see below.

Legislative PublishingOffice of the Attorney General

Chancery Place675 King StreetP.O. Box 6000

Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-2520E-mail: [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette andleft with the commissionaire.

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/gazette_royale.html

Nous offrons sur demande des exemplaires de la Gazetteroyale à l’adresse suivante pour la somme de 4 $ l’exemplaire,plus la taxe de 5 % ainsi que les frais applicables de port et demanutention.

Avis : Le numéro de téléphone de la Gazette royale a changé.Prière de voir ci-dessous.

Publications législativesCabinet du procureur général

Place-Chancery675, rue King

C.P. 6000Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tél. : 506-453-2520Courriel : [email protected]

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doitêtre remise au commissionnaire.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés